VERTCELL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVERTCELL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01304309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VERTCELL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VERTCELL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VERTCELL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per VERTCELL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 feb 2021

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di VERTCELL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British110894220002
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish229010610001
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2304195
    110674970001
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British75618940001
    BOOTH, Brenda
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    Segretario
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    British16249170005
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    PERRY, Brian
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    British10759770001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    BIGGS, Anthony Mark
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46681000002
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Amministratore
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritish29331220001
    BROWN, Angus Lushington Wylie
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    British10759780001
    DAVIS, Andrew Michael
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish63557750001
    DAY, John Osborne
    5 Camellia Way
    Simons Park
    RG41 3NB Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    5 Camellia Way
    Simons Park
    RG41 3NB Wokingham
    Berkshire
    British76450060001
    EGERTON, Peter John
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    Amministratore
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    British17294880001
    FAIRGRIEVE, Thomas Darling
    6 Floors Place
    KY2 5SF Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    6 Floors Place
    KY2 5SF Kirkcaldy
    Fife
    British708420001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritish55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    MURRAY, Alec Barclay
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish163818290001
    QUICK, James Anthony
    The Spinney 106 Park Road
    Hale
    WA15 9JT Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    The Spinney 106 Park Road
    Hale
    WA15 9JT Altrincham
    Cheshire
    British10759800001
    ROYLE, Frederick Alfred
    Overton 6 Woodhead Road
    Hale
    WA15 9LD Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Overton 6 Woodhead Road
    Hale
    WA15 9LD Altrincham
    Cheshire
    British13008590002
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VERTCELL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bramall Quicks Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione158215
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    VERTCELL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed to the guarantee and debenture
    Creato il 22 ago 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Target guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties
    Creato il 13 giu 2002
    Consegnato il 21 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 dic 1997
    Consegnato il 09 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to each lender under each designated finance document (as defined) except for: any obligation which is excluded under clause 4.2 of the intercreditor agreement (as defined) and any obligation which if it were so included would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985 (the "secured liabilities")
    Brevi particolari
    L/H unit 11 ringway trading estate shadowmoss road wythenshawe manchester M22 5LH f/h land and buildings on the south east side of manchester road altrincham WA14 5LZ t/n GM569388 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 nov 1997
    Consegnato il 25 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 nov 1997
    Consegnato il 22 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 22 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1977
    Consegnato il 09 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings formerly known as tiffanys gas street, ashton under lyne greater manchester as comprised in a transfer dated 29.4.77.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0