CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED

CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCMGRP MARKETING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01306069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WEBER EUROPE LIMITED10 feb 200410 feb 2004
    GOLIN/HARRIS INTERNATIONAL LIMITED24 feb 200024 feb 2000
    PARAGON GOLIN/HARRIS LIMITED11 ago 199811 ago 1998
    PARAGON COMMUNICATIONS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    FENDI (U.K. LEATHERWEAR) LIMITED31 mar 197731 mar 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 nov 2022

    20 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    10 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Modifica dei dettagli di Golin/Harris International Limited come persona con controllo significativo il 19 mag 2022

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3AN England a 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes MK5 8PJ in data 13 dic 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 nov 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3AN England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN

    2 pagineAD02

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 ott 2021

    • Capitale: GBP 2,531,635.25
    3 pagineSH01

    Nomina di Mr Andrew Cooper Page come amministratore in data 26 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Derek John Coleman come amministratore in data 26 ott 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Topping come amministratore in data 26 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Richard Neale come amministratore in data 26 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Debra Susan Nichols come amministratore in data 26 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Brian James Beck come amministratore in data 26 ott 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3 Grosvenor Gardens London SW1W 0BD England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2N 3AN England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN in data 24 mag 2021

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3TP England a 135 Bishopsgate London EC2N 3AN in data 24 mag 2021

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Golin/Harris International Limited come persona con controllo significativo il 02 ott 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Grosvenor Gardens London SW1W 0BD a 135 Bishopsgate London EC2M 3TP in data 02 ott 2020

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEAN, Louise
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    Segretario
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    British88994320002
    COLEMAN, Derek John
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    Amministratore
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    EnglandBritish13627400011
    PAGE, Andrew Cooper
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    Amministratore
    Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    1
    EnglandBritish240246840001
    BECK, Brian James
    707 N Ottawa Avenue
    Park Ridge
    Illinois 60068
    Usa
    Segretario
    707 N Ottawa Avenue
    Park Ridge
    Illinois 60068
    Usa
    British91518680001
    FEI, Peter Benedetto
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Segretario
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    British44197080001
    GREENE, Kevin Michael
    39 Tudor Drive
    KT2 5NW Kingston Upon Thames
    London
    Segretario
    39 Tudor Drive
    KT2 5NW Kingston Upon Thames
    London
    Irish63939720003
    GUERIN, Julia Maria
    21 Wadham Gardens
    UB6 0BP Greenford
    Middlesex
    Segretario
    21 Wadham Gardens
    UB6 0BP Greenford
    Middlesex
    New Zealander72542350001
    JONES, Susan Lynne
    14 West Park Avenue
    TW9 4AL Richmond
    Surrey
    Segretario
    14 West Park Avenue
    TW9 4AL Richmond
    Surrey
    British80241030002
    THORN, Julia Denise
    23 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Segretario
    23 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    British29404560001
    WILSON, John Laurence Anthony Ashley
    20 Filigree Court
    Rotherhithe
    SE16 1HL London
    Segretario
    20 Filigree Court
    Rotherhithe
    SE16 1HL London
    British30891890001
    BECK, Brian James
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    United StatesAmerican162507730001
    BLENKISOP, Charlotte Anne
    105 Cowley Road
    Mortlake
    SW14 8QD London
    Amministratore
    105 Cowley Road
    Mortlake
    SW14 8QD London
    British48409750001
    BONDY, Jessica
    42e Compayne Gardens
    NW6 3RY London
    Amministratore
    42e Compayne Gardens
    NW6 3RY London
    British74506580001
    BROWN, Christine
    Barnaby Dickensian Close
    Upper Stoke
    ME3 9TB Rochester
    Kent
    Amministratore
    Barnaby Dickensian Close
    Upper Stoke
    ME3 9TB Rochester
    Kent
    British78771870001
    COWDRY, Quentin
    Flat 3 9 Devonhurst Place
    Heathfield Terrace
    W4 4JB London
    Amministratore
    Flat 3 9 Devonhurst Place
    Heathfield Terrace
    W4 4JB London
    British94026670001
    DAVIS, Mark Beaumont
    Dauntsey Cottage
    Dauntsey Drove Weyhill
    SP12 8EQ Andover
    Amministratore
    Dauntsey Cottage
    Dauntsey Drove Weyhill
    SP12 8EQ Andover
    British48409770001
    EVANS, Ceri Garfield
    110 Devonshire Road
    SE23 3SX London
    Amministratore
    110 Devonshire Road
    SE23 3SX London
    British60259730003
    FARR, Susan Jane
    6 The Gables
    55 Netherhall Gardens
    NW3 5RH London
    Amministratore
    6 The Gables
    55 Netherhall Gardens
    NW3 5RH London
    British94820780001
    FEI, Peter Benedetto
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Amministratore
    29 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    EnglandBritish44197080001
    GREENE, Kevin Michael
    39 Tudor Drive
    KT2 5NW Kingston Upon Thames
    London
    Amministratore
    39 Tudor Drive
    KT2 5NW Kingston Upon Thames
    London
    EnglandIrish63939720003
    GUERIN, Julia Maria
    21 Wadham Gardens
    UB6 0BP Greenford
    Middlesex
    Amministratore
    21 Wadham Gardens
    UB6 0BP Greenford
    Middlesex
    New Zealander72542350001
    HAMID, Mohamed Arif
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    England
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    England
    EnglandBritish51714150002
    HUGHES, Jonathan Paul Ashley
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    EnglandBritish254803150001
    JONES, Susan Lynne
    14 West Park Avenue
    TW9 4AL Richmond
    Surrey
    Amministratore
    14 West Park Avenue
    TW9 4AL Richmond
    Surrey
    British80241030002
    JOY, Larissa
    20 Dorset Square
    NW1 6QB London
    Amministratore
    20 Dorset Square
    NW1 6QB London
    British58097930001
    KIRKCALDY, James Craig
    8 Cheltenham Avenue
    Ben Rhydding
    LS29 8BN Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Cheltenham Avenue
    Ben Rhydding
    LS29 8BN Ilkley
    West Yorkshire
    British35689830001
    KNIGHT, Gordon John
    3 Ellenborough Place
    Roehampton
    SW15 5LZ London
    Amministratore
    3 Ellenborough Place
    Roehampton
    SW15 5LZ London
    British15528700001
    LEGETTER, Barry
    2 Ross Way
    SS16 6LX Langdon Hills
    Essex
    Amministratore
    2 Ross Way
    SS16 6LX Langdon Hills
    Essex
    British83796250001
    LUMSDEN, Richard
    26 Grange Road
    CO11 2ND Lawford
    Essex
    Amministratore
    26 Grange Road
    CO11 2ND Lawford
    Essex
    EnglandBritish89606090001
    MILLS, Lorraine
    Cotehele
    Upper Farringdon
    GU34 3DT Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Cotehele
    Upper Farringdon
    GU34 3DT Alton
    Hampshire
    British60040860002
    NEALE, Matthew Richard
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    United StatesBritish266944220001
    NEALE, Matthew Richard
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    3
    EnglandBritish179993110002
    NICHOLS, Debra Susan
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AN London
    135
    England
    United StatesAmerican228643670001
    PATERSON, William Crawford
    Hudnall Common Farm
    HP4 Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hudnall Common Farm
    HP4 Little Gaddesden
    Hertfordshire
    British31054240001
    PERRY, Philip James Erskine
    15 Burgess Mead
    OX2 6XP Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    15 Burgess Mead
    OX2 6XP Oxford
    Oxfordshire
    British31292620009

    Chi sono le persone con controllo significativo di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Golin Limited
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    06 apr 2016
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione2713976
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission
    Creato il 15 dic 1992
    Consegnato il 18 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M536C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(For Itself and as Agent and Trustee for the Banks as So Defined)
    Transazioni
    • 18 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 15 dic 1992
    Consegnato il 18 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all revenues. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Shandwick Plcor Any Other Ultimate Holding Company as So Defined
    Transazioni
    • 18 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 mar 1983
    Consegnato il 28 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Series of debentures
    Creato il 18 mag 1981
    Consegnato il 02 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 02 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 nov 2021Inizio della liquidazione
    13 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Birne
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Praticante
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Gareth David Wilcox
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praticante
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Steven John Parker
    322 High Holborn
    WC1V 7PB London
    Praticante
    322 High Holborn
    WC1V 7PB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0