CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01306069 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
- Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WEBER EUROPE LIMITED | 10 feb 2004 | 10 feb 2004 |
| GOLIN/HARRIS INTERNATIONAL LIMITED | 24 feb 2000 | 24 feb 2000 |
| PARAGON GOLIN/HARRIS LIMITED | 11 ago 1998 | 11 ago 1998 |
| PARAGON COMMUNICATIONS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| FENDI (U.K. LEATHERWEAR) LIMITED | 31 mar 1977 | 31 mar 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 nov 2022 | 20 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 10 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Golin/Harris International Limited come persona con controllo significativo il 19 mag 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3AN England a 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes MK5 8PJ in data 13 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3AN England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 ott 2021
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Cooper Page come amministratore in data 26 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Derek John Coleman come amministratore in data 26 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Topping come amministratore in data 26 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Richard Neale come amministratore in data 26 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Debra Susan Nichols come amministratore in data 26 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brian James Beck come amministratore in data 26 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3 Grosvenor Gardens London SW1W 0BD England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2N 3AN England a 135 Bishopsgate London EC2M 3AN in data 24 mag 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3TP England a 135 Bishopsgate London EC2N 3AN in data 24 mag 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Golin/Harris International Limited come persona con controllo significativo il 02 ott 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 Grosvenor Gardens London SW1W 0BD a 135 Bishopsgate London EC2M 3TP in data 02 ott 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAN, Louise | Segretario | Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes 1 | British | 88994320002 | ||||||
| COLEMAN, Derek John | Amministratore | Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes 1 | England | British | 13627400011 | |||||
| PAGE, Andrew Cooper | Amministratore | Radian Court Knowlhill MK5 8PJ Milton Keynes 1 | England | British | 240246840001 | |||||
| BECK, Brian James | Segretario | 707 N Ottawa Avenue Park Ridge Illinois 60068 Usa | British | 91518680001 | ||||||
| FEI, Peter Benedetto | Segretario | 29 Airedale Avenue W4 2NW London | British | 44197080001 | ||||||
| GREENE, Kevin Michael | Segretario | 39 Tudor Drive KT2 5NW Kingston Upon Thames London | Irish | 63939720003 | ||||||
| GUERIN, Julia Maria | Segretario | 21 Wadham Gardens UB6 0BP Greenford Middlesex | New Zealander | 72542350001 | ||||||
| JONES, Susan Lynne | Segretario | 14 West Park Avenue TW9 4AL Richmond Surrey | British | 80241030002 | ||||||
| THORN, Julia Denise | Segretario | 23 Manor Way Blackheath SE3 9EF London | British | 29404560001 | ||||||
| WILSON, John Laurence Anthony Ashley | Segretario | 20 Filigree Court Rotherhithe SE16 1HL London | British | 30891890001 | ||||||
| BECK, Brian James | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AN London 135 England | United States | American | 162507730001 | |||||
| BLENKISOP, Charlotte Anne | Amministratore | 105 Cowley Road Mortlake SW14 8QD London | British | 48409750001 | ||||||
| BONDY, Jessica | Amministratore | 42e Compayne Gardens NW6 3RY London | British | 74506580001 | ||||||
| BROWN, Christine | Amministratore | Barnaby Dickensian Close Upper Stoke ME3 9TB Rochester Kent | British | 78771870001 | ||||||
| COWDRY, Quentin | Amministratore | Flat 3 9 Devonhurst Place Heathfield Terrace W4 4JB London | British | 94026670001 | ||||||
| DAVIS, Mark Beaumont | Amministratore | Dauntsey Cottage Dauntsey Drove Weyhill SP12 8EQ Andover | British | 48409770001 | ||||||
| EVANS, Ceri Garfield | Amministratore | 110 Devonshire Road SE23 3SX London | British | 60259730003 | ||||||
| FARR, Susan Jane | Amministratore | 6 The Gables 55 Netherhall Gardens NW3 5RH London | British | 94820780001 | ||||||
| FEI, Peter Benedetto | Amministratore | 29 Airedale Avenue W4 2NW London | England | British | 44197080001 | |||||
| GREENE, Kevin Michael | Amministratore | 39 Tudor Drive KT2 5NW Kingston Upon Thames London | England | Irish | 63939720003 | |||||
| GUERIN, Julia Maria | Amministratore | 21 Wadham Gardens UB6 0BP Greenford Middlesex | New Zealander | 72542350001 | ||||||
| HAMID, Mohamed Arif | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British | 51714150002 | |||||
| HUGHES, Jonathan Paul Ashley | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 | England | British | 254803150001 | |||||
| JONES, Susan Lynne | Amministratore | 14 West Park Avenue TW9 4AL Richmond Surrey | British | 80241030002 | ||||||
| JOY, Larissa | Amministratore | 20 Dorset Square NW1 6QB London | British | 58097930001 | ||||||
| KIRKCALDY, James Craig | Amministratore | 8 Cheltenham Avenue Ben Rhydding LS29 8BN Ilkley West Yorkshire | British | 35689830001 | ||||||
| KNIGHT, Gordon John | Amministratore | 3 Ellenborough Place Roehampton SW15 5LZ London | British | 15528700001 | ||||||
| LEGETTER, Barry | Amministratore | 2 Ross Way SS16 6LX Langdon Hills Essex | British | 83796250001 | ||||||
| LUMSDEN, Richard | Amministratore | 26 Grange Road CO11 2ND Lawford Essex | England | British | 89606090001 | |||||
| MILLS, Lorraine | Amministratore | Cotehele Upper Farringdon GU34 3DT Alton Hampshire | British | 60040860002 | ||||||
| NEALE, Matthew Richard | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AN London 135 England | United States | British | 266944220001 | |||||
| NEALE, Matthew Richard | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 | England | British | 179993110002 | |||||
| NICHOLS, Debra Susan | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AN London 135 England | United States | American | 228643670001 | |||||
| PATERSON, William Crawford | Amministratore | Hudnall Common Farm HP4 Little Gaddesden Hertfordshire | British | 31054240001 | ||||||
| PERRY, Philip James Erskine | Amministratore | 15 Burgess Mead OX2 6XP Oxford Oxfordshire | British | 31292620009 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golin Limited | 06 apr 2016 | Bishopsgate EC2M 3TP London 135 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission | Creato il 15 dic 1992 Consegnato il 18 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See doc ref M536C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission | Creato il 15 dic 1992 Consegnato il 18 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over all revenues. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 23 mar 1983 Consegnato il 28 mar 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Series of debentures | Creato il 18 mag 1981 Consegnato il 02 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | ||
Transazioni
| ||||
CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0