CENTRELINK EXPRESS LIMITED

CENTRELINK EXPRESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTRELINK EXPRESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01307163
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SMITH & WILLIAMSON LLP
    3rd Floor 9
    Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    West Midlands
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FARLEYER HOUSE HOTEL LIMITED12 mag 199412 mag 1994
    SOUTHSTREAM LIMITED06 apr 197706 apr 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Btg Tax 19 George Road Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1NU in data 14 giu 2012

    1 pagineAD01

    Stato del capitale al 13 giu 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 24/05/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Shaw come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Shaw come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Janice Anne Reid il 25 mar 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di CENTRELINK EXPRESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REID, Derek Donald
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    Amministratore
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    ScotlandBritish24165790005
    REID, Janice Anne
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    Amministratore
    Broomhill
    Kinclaven
    PH1 4QL Stanley
    Perthshire
    ScotlandNew Zealand37962070002
    ATKINS, Gerald
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Segretario
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53861890001
    REID, Derek Donald
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    Segretario
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    British24165790003
    SHAW, Andrew Charles
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    British29924060011
    ATKINS, Frances
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53862050001
    ATKINS, Gerald
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Farleyer Field House
    PH25 2JE Aberfeldy
    Perthshire
    British53861890001
    HEATH, Anthony
    Kildinny Farm
    Forteviot
    PH2 9DD Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Kildinny Farm
    Forteviot
    PH2 9DD Perth
    Perthshire
    British73926030001
    REID, Derek Donald
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    Amministratore
    Bonhard House
    PH2 7PQ Scone
    Perthshire
    British24165790003
    SHAW, Andrew Charles
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Barley House
    2 The Granary, Besford
    WR8 9BY Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish29924060011
    SINEL, Malcolm Leslie
    Oaklands
    La Rue De La Frontiere, St. Mary
    JE3 3EG Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Oaklands
    La Rue De La Frontiere, St. Mary
    JE3 3EG Jersey
    Channel Islands
    British66336350001
    WHITE, Andrew Nicholas
    Panmure Taybridge Road
    PH15 2BH Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Panmure Taybridge Road
    PH15 2BH Aberfeldy
    Perthshire
    British43824820001
    WHITE, Jonathon Grenville
    La Heche
    Rue Du Fliquet St Martin
    JE3 6BP Jersey
    Amministratore
    La Heche
    Rue Du Fliquet St Martin
    JE3 6BP Jersey
    United KingdomBritish61996120001

    CENTRELINK EXPRESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19/12/96
    Creato il 22 dic 1995
    Consegnato il 31 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Farleyer house hotel,farleyer,by aberfeldy,perthshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security.
    Creato il 18 set 1991
    Consegnato il 03 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • Cokato Holdings Limited.
    Transazioni
    • 03 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 17 set 1991
    Consegnato il 27 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,000 under the terms of a loan agreement dated 9TH sept. 1991.
    Brevi particolari
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • Mrs Frances Elizabeth Atkins
    Transazioni
    • 27 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security.
    Creato il 17 set 1991
    Consegnato il 27 set 1991
    In corso
    Importo garantito
    £11,000 under the terms of a loan agreement dated 9TH sept, 1991.
    Brevi particolari
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • Mr Gerald Atkins.
    Transazioni
    • 27 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    Bond and floating charge
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 20 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of a loan agreement dated 9TH sept. 1991
    Brevi particolari
    (See form 395 relevant to this charge).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Gerald Atkins
    Transazioni
    • 20 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Bond and floating charge
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 20 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of a loan agreement dated 9TH sept. 1991
    Brevi particolari
    (See form 395 relevant to this charge).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Frances Elizabeth Atkins
    Transazioni
    • 20 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Bond and floating charge
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 11 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dtd 09/09/91
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Cokato Holdings Limited
    Transazioni
    • 11 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1990
    Consegnato il 20 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395 and schedule relevant to this charge).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 20 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 25TH october 1990
    Creato il 25 ott 1990
    Consegnato il 02 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Farleyer house and policies, aberfeldy, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 02 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland.
    Creato il 02 nov 1988
    Consegnato il 19 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Part & portion of the estate of farleyer in the county of perth (26.8 hectares).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1988
    Consegnato il 10 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old plow inn flowers bottom speen, aylesbury, buckinghamshire. T/no:- bm 94450.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 gen 1987
    Consegnato il 21 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    "The old plow inn" flowers bottom speen near lacey green buckinghamshire and the assignment of the goodwill of the business floating charge undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Finance Company Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0