GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED

GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01308540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRADEL LIMITED10 ott 199010 ott 1990
    GLOBOL CHEMICALS (U.K.) LIMITED 31 dic 197731 dic 1977
    DACEVILLE LIMITED14 apr 197714 apr 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al29 mar 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma12 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al29 mar 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Howard William Nicholson come amministratore in data 31 ott 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP United Kingdom a Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    4 pagineAA

    Nomina di Mark William Strickland come amministratore in data 07 giu 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Huan George Quayle come segretario in data 31 mar 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di David Thomas Rattigan come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Howard William Nicholson come amministratore in data 31 gen 2020

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Huan George Quayle come segretario in data 15 gen 2018

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Christopher Ian Charles
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United Kingdom
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant194353920001
    STRICKLAND, Mark William
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United KingdomBritishDirector284037180001
    BARNET, Carole Ann
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Segretario
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    British687900001
    CASSIDY, Thomas
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    Segretario
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    British7907120001
    QUAYLE, Huan George
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Segretario
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    242194290001
    BARNET, Carole Ann
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Robert Mcbride Ltd
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Robert Mcbride Ltd
    EnglandBritishCompany Secretary687900001
    BARRISKELL, Simon Francis
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United KingdomBritishAccountant159313890002
    BUDSWORTH, John Philip
    High Jays Hare Lane
    Little Kingshill
    HP16 0EF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    High Jays Hare Lane
    Little Kingshill
    HP16 0EF Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishChemical Engineer49974970001
    CASSIDY, Thomas
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    Amministratore
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    BritishDirector7907120001
    CATLEY, Bryan Cecil Oliver
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    Amministratore
    Rock House
    Berry Head Road
    TQ5 9AA Brixham
    Devon
    EnglishDirector5960280001
    HANDLEY, Michael
    5 Meryton House
    Imperial Park Imperial Road
    SL4 3TW Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    5 Meryton House
    Imperial Park Imperial Road
    SL4 3TW Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive11908890002
    LINDSAY, Andrew
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United KingdomBritishAccountant78337450002
    MCINTYRE, Colin Stuart
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    EnglandBritishManaging Director196049590001
    MONKS, Terence John
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant80344460001
    MURFIN, Andrew James
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director68921430001
    NICHOLSON, Howard William
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    United KingdomBritishFinance Director158054790002
    RATTIGAN, David Thomas
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Amministratore
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    EnglandBritishAccountant267716900001
    SEAMAN, Timothy Nicholas Motum
    Durran
    Haslingden Road
    BB4 6QX Rawtenstall
    Lancashire
    Amministratore
    Durran
    Haslingden Road
    BB4 6QX Rawtenstall
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant126365880001
    SEAMAN, Timothy Nicholas Motum
    Durran
    Haslingden Road
    BB4 6QX Rawtenstall
    Lancashire
    Amministratore
    Durran
    Haslingden Road
    BB4 6QX Rawtenstall
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant126365880001
    VON PHILIPP, Fritz Valentin
    Auf Der Klause
    8858 Neuburg
    Germany
    Amministratore
    Auf Der Klause
    8858 Neuburg
    Germany
    GermanStudent11683030001
    VON PHILIPP, Fritz Alexander
    Auf Der Klause
    8858 Neuburg
    Germany
    Amministratore
    Auf Der Klause
    8858 Neuburg
    Germany
    GermanDirector77163280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Culmstock Limited
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Mcbride
    England
    06 apr 2016
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Mcbride
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk England
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione1199186
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mcbride Plc
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Mcbride
    England
    06 apr 2016
    Middleton Way
    Middleton
    M24 4DP Manchester
    Mcbride
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk England
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione2798634
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 16 ago 1996
    Consegnato il 22 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 3 bampton industrial estate, station road, bampton, devon t/no. DN363288 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 giu 1996
    Consegnato il 20 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property situate at exebridge industrial estate exebridge bampton devon t/n dn 253654 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1995
    Consegnato il 23 nov 1995
    In corso
    Importo garantito
    £57,500 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Unit 3 bampton industrial estate station road bampton.
    Persone aventi diritto
    • Frances Doreen Jones
    • Clifford George Jones
    Transazioni
    • 23 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 08 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings lying on the south side of central avenue lee mill ivybridge devon t/n dn 150800 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 30 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east and west of station road bampton devon t/n dn 277302 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1982
    Consegnato il 07 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as units 1 & 2 bampton industrial estate, nr tiverton, devon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 07 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 feb 1978
    Consegnato il 10 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc M16).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 10 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0