GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01308540 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TRADEL LIMITED | 10 ott 1990 | 10 ott 1990 |
GLOBOL CHEMICALS (U.K.) LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
DACEVILLE LIMITED | 14 apr 1977 | 14 apr 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 29 mar 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 12 apr 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 29 mar 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Howard William Nicholson come amministratore in data 31 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP United Kingdom a Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 pagine | AD02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 4 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 4 pagine | AA | ||
Nomina di Mark William Strickland come amministratore in data 07 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Huan George Quayle come segretario in data 31 mar 2020 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 4 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di David Thomas Rattigan come amministratore in data 31 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Howard William Nicholson come amministratore in data 31 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 pagine | AD02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Huan George Quayle come segretario in data 15 gen 2018 | 2 pagine | AP03 | ||
Chi sono gli amministratori di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Christopher Ian Charles | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 194353920001 | ||||
STRICKLAND, Mark William | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Director | 284037180001 | ||||
BARNET, Carole Ann | Segretario | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | British | 687900001 | ||||||
CASSIDY, Thomas | Segretario | Rock House Berry Head Road TQ5 9AA Brixham Devon | British | 7907120001 | ||||||
QUAYLE, Huan George | Segretario | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | 242194290001 | |||||||
BARNET, Carole Ann | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester Robert Mcbride Ltd | England | British | Company Secretary | 687900001 | ||||
BARRISKELL, Simon Francis | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Accountant | 159313890002 | ||||
BUDSWORTH, John Philip | Amministratore | High Jays Hare Lane Little Kingshill HP16 0EF Great Missenden Buckinghamshire | British | Chemical Engineer | 49974970001 | |||||
CASSIDY, Thomas | Amministratore | Rock House Berry Head Road TQ5 9AA Brixham Devon | British | Director | 7907120001 | |||||
CATLEY, Bryan Cecil Oliver | Amministratore | Rock House Berry Head Road TQ5 9AA Brixham Devon | English | Director | 5960280001 | |||||
HANDLEY, Michael | Amministratore | 5 Meryton House Imperial Park Imperial Road SL4 3TW Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 11908890002 | ||||
LINDSAY, Andrew | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Accountant | 78337450002 | ||||
MCINTYRE, Colin Stuart | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | England | British | Managing Director | 196049590001 | ||||
MONKS, Terence John | Amministratore | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 80344460001 | |||||
MURFIN, Andrew James | Amministratore | 48 Hawthorne Way Shelley HD8 8JX Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 68921430001 | ||||
NICHOLSON, Howard William | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Finance Director | 158054790002 | ||||
RATTIGAN, David Thomas | Amministratore | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | England | British | Accountant | 267716900001 | ||||
SEAMAN, Timothy Nicholas Motum | Amministratore | Durran Haslingden Road BB4 6QX Rawtenstall Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 126365880001 | ||||
SEAMAN, Timothy Nicholas Motum | Amministratore | Durran Haslingden Road BB4 6QX Rawtenstall Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 126365880001 | ||||
VON PHILIPP, Fritz Valentin | Amministratore | Auf Der Klause 8858 Neuburg Germany | German | Student | 11683030001 | |||||
VON PHILIPP, Fritz Alexander | Amministratore | Auf Der Klause 8858 Neuburg Germany | German | Director | 77163280001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culmstock Limited | 06 apr 2016 | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester Mcbride England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mcbride Plc | 06 apr 2016 | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester Mcbride England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
GLOBOL PROPERTIES (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 16 ago 1996 Consegnato il 22 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a unit 3 bampton industrial estate, station road, bampton, devon t/no. DN363288 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 17 giu 1996 Consegnato il 20 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property situate at exebridge industrial estate exebridge bampton devon t/n dn 253654 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 nov 1995 Consegnato il 23 nov 1995 | In corso | Importo garantito £57,500 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Unit 3 bampton industrial estate station road bampton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 29 nov 1994 Consegnato il 08 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land and buildings lying on the south side of central avenue lee mill ivybridge devon t/n dn 150800 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 23 giu 1992 Consegnato il 30 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the east and west of station road bampton devon t/n dn 277302 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 23 dic 1982 Consegnato il 07 gen 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as units 1 & 2 bampton industrial estate, nr tiverton, devon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 06 feb 1978 Consegnato il 10 feb 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc M16). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0