HALLITE POLYTEK LIMITED

HALLITE POLYTEK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHALLITE POLYTEK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01308929
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HALLITE POLYTEK LIMITED?

    • fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (20160) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLITE DEVELOPMENTS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    HALLITE BELLOWS LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    TRUSHELFCO (NO. 134) LIMITED15 apr 197715 apr 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 gen 2021

    8 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 gen 2020

    8 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW a C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL in data 06 feb 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 gen 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 gen 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The company share premium account cancelled 13/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Richard William Hewlett come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vijay Markanday come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William John Pratt il 10 set 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 ago 2017, non revisionato

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William John Pratt il 16 mar 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Simon Alan Davies come amministratore in data 05 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2015

    Stato del capitale al 04 ago 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADBURY, Debra
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Segretario
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    British72879990002
    CALEY, Andrew Maitland
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Amministratore
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish49060800002
    PRATT, William John
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    Amministratore
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish194710300003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Segretario
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    British69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Segretario
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    British119450490001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Segretario
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    BENNETT, Peter Ian
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    British4154020001
    CHAFFIN, Peter
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    British1508410001
    DAVIES, Simon Alan
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    British44598860003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Great BritainBritish69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Amministratore
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    EnglandBritish119450490001
    HEWLETT, Richard William
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    Amministratore
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    British59434460001
    HOWIE, Andrew Wright
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    Amministratore
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    British15413650001
    JONES, David Henry
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    Amministratore
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    United KingdomBritish101383260001
    KINGSNORTH, Robert Stanley
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    Amministratore
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British58131230001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    MUMFORD, Michael Charles
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    British18807630002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PERRY, Richard John
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    Amministratore
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish40260860002
    RUBERY, Steven Henry
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    Amministratore
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    British15413670001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    WESTON, Peter Maurice
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    EnglandBritish112416950001
    WILKINS, Christopher Stuart Henry
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish127017930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HALLITE POLYTEK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01104611
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HALLITE POLYTEK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 set 1998
    Consegnato il 22 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 21 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the agreement (as defined in the original debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself the Arranger and for the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 21 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 23 feb 1990
    Consegnato il 13 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself, the arranger & the banks (as defined in the original debenture being 2 debentures dated 27.7.89 & 1.9.89) an any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined in the original debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 set 1989
    Consegnato il 05 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company as agent and trustee for itself, the arranger and for the danks under the terms of the agreement and ancilliary facility and/or any other security documents
    Brevi particolari
    (For full details see doc. M372).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Company Limited
    Transazioni
    • 05 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creato il 25 ago 1989
    Consegnato il 05 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.(For Itself and as Trustee for the Lendes)
    Transazioni
    • 05 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creato il 27 lug 1989
    Consegnato il 17 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transazioni
    • 17 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & second debenture
    Creato il 27 lug 1989
    Consegnato il 07 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from and/or all or any of the other companies named therein under the terms of a mezzanine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed. The company to the chargee.
    Brevi particolari
    (See form 395 - ref M541C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Frist Britannia Mezzenine Capital B.V.(As Trustee for the Lenders.)
    Transazioni
    • 07 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 lug 1989
    Consegnato il 07 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agrent and trustee for itself the arrange and for the banks) on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27.7.89, the ancillary facility and the security documents (as defined in the facility agreement).
    Brevi particolari
    For further details see doc M106).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited.
    Transazioni
    • 07 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HALLITE POLYTEK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 gen 2019Inizio della liquidazione
    15 dic 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Praticante
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0