COLGATE MEDICAL LIMITED

COLGATE MEDICAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLGATE MEDICAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01311455
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLGATE MEDICAL LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTAVENT ORTHOFIX LIMITED30 dic 199430 dic 1994
    COLGATE MEDICAL LIMITED08 feb 199008 feb 1990
    D J COLGATE MEDICAL LIMITED29 apr 197729 apr 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 013114550013

    1 pagineMR05

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Joseph Brent Alldredge come amministratore in data 05 lug 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Burney Court Cordwallis Park Maidenhead Berkshire SL6 7BZ a 15 Canada Square London E14 5GL in data 19 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 set 2018

    LRESSP

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 set 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 19/09/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Brent Alldredge il 05 lug 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Joseph Brent Alldredge come amministratore in data 05 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeff Michael Schumm come amministratore in data 05 lug 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Stacy Leann Kohn come amministratore in data 01 mag 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maritza Vazquez Royall come amministratore in data 23 apr 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2016

    Stato del capitale al 22 feb 2016

    • Capitale: GBP 497,881
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Douglas Clinton Rice il 01 gen 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARRY, Michael John
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish179235030001
    KOHN, Stacy Leann
    Plano Parkway
    75056 Lewisville
    3451
    Tx
    United States
    Amministratore
    Plano Parkway
    75056 Lewisville
    3451
    Tx
    United States
    United StatesAmerican208967510001
    RICE, Douglas Clinton
    Plano Parkway
    Lewisville
    3451
    Tx 75056
    United States
    Amministratore
    Plano Parkway
    Lewisville
    3451
    Tx 75056
    United States
    United StatesAmerican193755070001
    CLARKE, Peter William
    32 Murdoch Road
    RG40 2DF Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    32 Murdoch Road
    RG40 2DF Wokingham
    Berkshire
    British35789840001
    HEIN, Thomas Marshall
    17316 Connor Quay Court
    Cornelius
    North Carolina
    Nc28031
    Usa
    Segretario
    17316 Connor Quay Court
    Cornelius
    North Carolina
    Nc28031
    Usa
    American108739930002
    NICHOLL, Albert
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    British148054070001
    SENTANCE, Robert
    Robins Bottom Cottage
    Stubbs Hill Iping
    GU29 0PJ Midhurst
    West Sussex
    Segretario
    Robins Bottom Cottage
    Stubbs Hill Iping
    GU29 0PJ Midhurst
    West Sussex
    British37183540002
    UPTON, John Henry Peter
    47 Forlease Road
    SL6 1RX Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    47 Forlease Road
    SL6 1RX Maidenhead
    Berkshire
    British11375720001
    ALLDREDGE, Joseph Brent
    Plano Parkway
    75056 Lewisville
    3451
    Tx
    United States
    Amministratore
    Plano Parkway
    75056 Lewisville
    3451
    Tx
    United States
    United StatesAmerican210645580001
    BOGUSH, David
    35 Norrice Lea
    N2 0RD London
    Amministratore
    35 Norrice Lea
    N2 0RD London
    United KingdomBritish9577420001
    BUXTON, Emily Victoria
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    UsaAmerican179235500001
    CLARKE, Peter William
    32 Murdoch Road
    RG40 2DF Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    32 Murdoch Road
    RG40 2DF Wokingham
    Berkshire
    British35789840001
    DE GIORGIO-MILLER, Oliver
    St. Ibbs House
    London Road, St. Ippolyts
    SG4 7NL Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    St. Ibbs House
    London Road, St. Ippolyts
    SG4 7NL Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandMaltese155672770001
    GOLDBERG, Anthony
    37 Lyttelton Road
    N2 0DQ London
    Amministratore
    37 Lyttelton Road
    N2 0DQ London
    British19560510001
    GOODMAN, Bruce Henry
    Garth House Bath Road
    Midgham
    RG7 5XB Berkshire
    Amministratore
    Garth House Bath Road
    Midgham
    RG7 5XB Berkshire
    British42244500004
    GRATION, David Whitnall
    Maple Corner Maple Lane
    Upper Basildon
    RG8 8PF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Maple Corner Maple Lane
    Upper Basildon
    RG8 8PF Reading
    Berkshire
    British14238460001
    HASTINGS, Mark Alan
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish164450060001
    HEGGESTAD, Mark Allan
    Plano Parkway
    Lewisville
    3451
    Tx 75056
    Usa
    Amministratore
    Plano Parkway
    Lewisville
    3451
    Tx 75056
    Usa
    UsaUs Citizen188868080001
    HEIN, Thomas Marshall
    17316 Connor Quay Court
    Cornelius
    North Carolina
    Nc28031
    Usa
    Amministratore
    17316 Connor Quay Court
    Cornelius
    North Carolina
    Nc28031
    Usa
    American108739930002
    KOLLS, Raymond Charles
    13809 Tributary Court
    Davidson
    North Carolina Nc 28036
    Usa
    Amministratore
    13809 Tributary Court
    Davidson
    North Carolina Nc 28036
    Usa
    UsaAmerican114250170001
    MCCOLLUM, Brian
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    UsaAmerican139652670003
    MOULD, Galvin Harold Thomas
    Lambourne House
    College Way
    RG17 7EP East Garston
    Berkshire
    Amministratore
    Lambourne House
    College Way
    RG17 7EP East Garston
    Berkshire
    United KingdomBritish44989480003
    NICHOLL, Albert
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish138139480001
    PANTER, Michael Anthony
    The Cottage Cold Harbour Lane
    Goring Heath
    RG8 7SY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage Cold Harbour Lane
    Goring Heath
    RG8 7SY Reading
    Berkshire
    British4511820001
    ROWLEDGE, Peter Eric
    The Old Forge
    Stratford-St-Mary
    CO7 6JS Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Old Forge
    Stratford-St-Mary
    CO7 6JS Colchester
    Essex
    United KingdomBritish6479710001
    ROYALL, Maritza Vazquez
    Plano Parkway
    Lewisville
    Orthofix Inc. 3451
    Texas 75056
    Usa
    Amministratore
    Plano Parkway
    Lewisville
    Orthofix Inc. 3451
    Texas 75056
    Usa
    UsaUs Citizen194031640001
    SCHUMM, Jeff Michael
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BZ Maidenhead
    Berkshire
    UsaAmerican153543810001
    SENTANCE, Robert
    Robins Bottom Cottage
    Stubbs Hill Iping
    GU29 0PJ Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    Robins Bottom Cottage
    Stubbs Hill Iping
    GU29 0PJ Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish37183540002
    WALLNER, Edgar
    Somerville
    Bray Bray Road
    SL6 1VE Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Somerville
    Bray Bray Road
    SL6 1VE Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish27935680002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COLGATE MEDICAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BU Maidenhead
    5
    England
    06 apr 2016
    Burney Court
    Cordwallis Park
    SL6 7BU Maidenhead
    5
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2853159
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    COLGATE MEDICAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 ago 2015
    Consegnato il 04 set 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The scheduled intellectual property and all of the chargors' other intellectual property from time to time including: (a) all patents, trade marks, service marks, designs, business names, brand names, domain names, copyrights, database rights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, knowhow and other intellectual property rights and interests, whether registered or unregistered; and (b) the benefit of all applications and rights to use such assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transazioni
    • 04 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 nov 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Pledge agreement
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the credit parties to the lenders (including the issuing lender) and the chargee and from the credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider and all monies due or to become due to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the credit parties to the lenders (including the issuing lender) and the chargee and from the credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider and all monies due or to become due to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the credit parties to the lenders and the chargee and from any credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100% (or, if less, the full amount owned by such pledgor) of the issued and outstanding capital stock owned by such pledgor or each subsidiary, together with the capital stock and other interests, all shares, securities, membership interests or other equity interests representing a dividend on any of the pledged capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank (The Administrative Agent)
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the credit parties to the lenders and the chargee and from any credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest of such obligor in and to the following; all accounts all cash and cash equivalents, all chattel paper, those certain commercial tort claims, all copyright licenses, all copyrights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank (The Administrative Agent)
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 30 dic 2003
    Consegnato il 19 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the credit parties to the lenders and the administrative agent and all liabilities and obligations due from any credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest of such pledgor in and to 100% (or, if less, the full amount owned by such pledgor) of the issued and outstanding capital stock, all shares, securities, membership interests or other equity interests representing a dividend on any of the pledged capital stock. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank,National Association in Its Capacity as Administrative Agent Under the Creditagreement
    Transazioni
    • 19 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2003
    Consegnato il 19 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the credit parties to the lenders and the administrative agent and all liabilities and obligations due from any credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest of such obligor in and to the following; all accounts, all cash and cash equivalents, all chattel paper, those certain commercial tort claims, all copyright licenses, all copyrights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank,National Association in Its Capacity as Administrative Agent Under the Creditagreement
    Transazioni
    • 19 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 dic 2003
    Consegnato il 19 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the credit parties to the lenders and the administrative agent and all liabilities and obligations due from any credit party or any of its subsidiaries to any hedging agreement provider under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association in Its Capacity as Administrative Agent Under the Creditaggreement
    Transazioni
    • 19 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 mag 1989
    Consegnato il 25 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 21 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1987
    Consegnato il 31 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 20 mar 1987
    Consegnato il 24 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 23 12 86
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery. Stocks shares other securities.
    Persone aventi diritto
    • Electra Investment Trust P.L.C.
    Transazioni
    • 24 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 20 apr 1983
    Consegnato il 28 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts now & from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 28 apr 1983Registrazione di un'ipoteca

    COLGATE MEDICAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 set 2018Inizio della liquidazione
    07 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0