KELNIGAL EUROPE LIMITED

KELNIGAL EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKELNIGAL EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01315677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    200 Great Dover Street
    SE1 4YB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGH-POINT EUROPE LIMITED31 mar 199331 mar 1993
    C.T.M.S. (EUROPE) LIMITED31 mag 197731 mag 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 61 Southwark Street London SE1 1SA a 200 Great Dover Street London SE1 4YB in data 06 lug 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 dic 2015

    Stato del capitale al 29 dic 2015

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015

    7 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed high-point europe LIMITED\certificate issued on 04/08/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 22 giu 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 013156770005 in pieno

    4 pagineMR04

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 lug 2014 al 31 gen 2015

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 nov 2014

    Stato del capitale al 10 nov 2014

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2013

    Stato del capitale al 30 ott 2013

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 013156770005

    191 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2012

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Charlotte Louise Parsons il 06 lug 2012

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Charlotte Louise Parsons il 06 lug 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARSONS, Charlotte Louise
    Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PL Kent
    Orchard Cottage
    England
    Segretario
    Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PL Kent
    Orchard Cottage
    England
    British140414820001
    HINGLEY, Kelvin William Thomas
    Home Farm Building
    Swynnerton
    ST15 0RA Stone
    The Barn
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Home Farm Building
    Swynnerton
    ST15 0RA Stone
    The Barn
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish50467220002
    PARSONS, Charlotte Louise
    Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PL Kent
    Orchard Cottage
    England
    Amministratore
    Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PL Kent
    Orchard Cottage
    England
    United KingdomBritish140414820004
    ASHLEY, Robert Croft
    112 Rosemary Hill Road
    Little Aston
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    112 Rosemary Hill Road
    Little Aston
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British63892950002
    COX, David Dennis
    7 Top Road
    ST17 0RQ Acton Trussell
    Stafford
    Segretario
    7 Top Road
    ST17 0RQ Acton Trussell
    Stafford
    British84987910001
    DAVISON, Suzanne
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    Segretario
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    British80856470001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    LIVERMORE, Sarah
    65 Kingfisher Drive
    DA9 9RT Greenhithe
    Kent
    Segretario
    65 Kingfisher Drive
    DA9 9RT Greenhithe
    Kent
    British76075440002
    MEEK, Richard James
    Birch Cottage
    1b Nursery Gardens
    BR7 5BW Chislehurst
    Kent
    Segretario
    Birch Cottage
    1b Nursery Gardens
    BR7 5BW Chislehurst
    Kent
    New Zealand71052900001
    VINCENT, Susan Jane
    53 Cavendish Drive
    Hagley
    DY9 0LR Stourbridge
    Worcestershire
    Segretario
    53 Cavendish Drive
    Hagley
    DY9 0LR Stourbridge
    Worcestershire
    British95619190001
    BRADLEY, John
    8 Brackenwood Road
    Rooks Nest Outwood
    WF1 3TH Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Brackenwood Road
    Rooks Nest Outwood
    WF1 3TH Wakefield
    West Yorkshire
    British51073960001
    BROWN, Denis James
    85 Grange Road
    NE61 2TS Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    85 Grange Road
    NE61 2TS Morpeth
    Northumberland
    British20169780001
    CANNING, David John
    24 Aldbourne Avenue
    RG6 2DB Earley
    Reading Berkshire
    Amministratore
    24 Aldbourne Avenue
    RG6 2DB Earley
    Reading Berkshire
    British36745230001
    CORR, Geoff
    20 Cotswold Drive
    CV3 6EY Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    20 Cotswold Drive
    CV3 6EY Coventry
    West Midlands
    British20169800001
    DARLING, Stephen Lyon
    Archway Cottage
    Yorton Heath
    SY4 3EU Shrewsbury
    Amministratore
    Archway Cottage
    Yorton Heath
    SY4 3EU Shrewsbury
    United KingdomBritish72268220001
    DORMAN, Robert Malcolm
    210 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    210 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British40185340001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Amministratore
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    HILDEBRANDT, Michael Leslie
    Hafod Farm
    Gwaenysgor
    LL18 6EP Rhyl
    Flintshire
    Amministratore
    Hafod Farm
    Gwaenysgor
    LL18 6EP Rhyl
    Flintshire
    United KingdomBritish111294680001
    HOOKWAY, David Wilfred
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    British374710001
    JOHNSON, Peter
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    British11342310001
    JONES, Anne Elizabeth
    9 The Terraces
    Garner Street
    E2 9AQ London
    Amministratore
    9 The Terraces
    Garner Street
    E2 9AQ London
    Great BritainBritish32870900001
    MARSHALL, Graeme Richard Dickson
    19 Marden Road
    Staplehurst
    TN12 0NF Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    19 Marden Road
    Staplehurst
    TN12 0NF Tonbridge
    Kent
    British42931720001
    MARSHALL, John Jeremy
    Heathercroft
    33 Bittell Road
    B45 8LU Barnt Green
    Worcestershire
    Amministratore
    Heathercroft
    33 Bittell Road
    B45 8LU Barnt Green
    Worcestershire
    United KingdomBritish141401190001
    MCIVER, Michael James
    Larkhill Farm Oxford Road
    CV23 9QE Princethorpe
    Warwickshire
    Amministratore
    Larkhill Farm Oxford Road
    CV23 9QE Princethorpe
    Warwickshire
    British47658740001
    MITCHELHILL, Robert George
    Brackenridge
    Bednall Head
    Stafford
    Staffs
    Amministratore
    Brackenridge
    Bednall Head
    Stafford
    Staffs
    British12614170001
    MORRIS, Michael Edward
    Dingle Hill
    Hollybush
    HR8 1EX Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Dingle Hill
    Hollybush
    HR8 1EX Ledbury
    Herefordshire
    British20169820001
    OLLERTON, Susan
    5 Barbers Lane
    Catherine De Barnes
    B92 0DH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    5 Barbers Lane
    Catherine De Barnes
    B92 0DH Solihull
    West Midlands
    British72001110002
    OSBALDSTONE, Albert Edward
    49 Woodlands Park
    Thornliebank
    G46 7RZ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    49 Woodlands Park
    Thornliebank
    G46 7RZ Glasgow
    Lanarkshire
    British20169840001
    PARFITT, Alun James
    River View Lodge Road
    Caerleon
    NP18 3QY Newport
    Gwent
    Amministratore
    River View Lodge Road
    Caerleon
    NP18 3QY Newport
    Gwent
    United KingdomBritish56694170001
    PYE, Derek
    134 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BJ Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    134 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BJ Wigan
    Lancashire
    British34280980001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    SMITH, Martin Christopher Geoffrey
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71281420001
    TAPPIN, Reginald George Richard
    Tudor Cottage
    3 Dome Hill
    CR3 6EE Caterham
    Surrey
    Amministratore
    Tudor Cottage
    3 Dome Hill
    CR3 6EE Caterham
    Surrey
    British2785080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KELNIGAL EUROPE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Nigel Stuart Bell
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 apr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Kelvin William Thomas Hingley
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 apr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    KELNIGAL EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 apr 2013
    Consegnato il 10 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • 20-20 Trustees Limited
    • Bridge Trustees Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high point rendel group PLC, vantagepoint management consultants (public sector) limited
    Creato il 04 lug 2001
    Consegnato il 24 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 09 ott 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 dic 1986
    Consegnato il 05 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1982
    Consegnato il 15 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 21 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0