KELNIGAL EUROPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KELNIGAL EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01315677 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KELNIGAL EUROPE LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 200 Great Dover Street SE1 4YB London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HIGH-POINT EUROPE LIMITED | 31 mar 1993 | 31 mar 1993 |
| C.T.M.S. (EUROPE) LIMITED | 31 mag 1977 | 31 mag 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 61 Southwark Street London SE1 1SA a 200 Great Dover Street London SE1 4YB in data 06 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed high-point europe LIMITED\certificate issued on 04/08/15 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 013156770005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 lug 2014 al 31 gen 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 013156770005 | 191 pagine | MR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Charlotte Louise Parsons il 06 lug 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Charlotte Louise Parsons il 06 lug 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSONS, Charlotte Louise | Segretario | Mapleton Road Four Elms TN8 6PL Kent Orchard Cottage England | British | 140414820001 | ||||||
| HINGLEY, Kelvin William Thomas | Amministratore | Home Farm Building Swynnerton ST15 0RA Stone The Barn Staffordshire England | United Kingdom | British | 50467220002 | |||||
| PARSONS, Charlotte Louise | Amministratore | Mapleton Road Four Elms TN8 6PL Kent Orchard Cottage England | United Kingdom | British | 140414820004 | |||||
| ASHLEY, Robert Croft | Segretario | 112 Rosemary Hill Road Little Aston B74 4HH Sutton Coldfield West Midlands | British | 63892950002 | ||||||
| COX, David Dennis | Segretario | 7 Top Road ST17 0RQ Acton Trussell Stafford | British | 84987910001 | ||||||
| DAVISON, Suzanne | Segretario | 106a Coppermill Lane Walthamstow E17 7HE London | British | 80856470001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Segretario | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| LIVERMORE, Sarah | Segretario | 65 Kingfisher Drive DA9 9RT Greenhithe Kent | British | 76075440002 | ||||||
| MEEK, Richard James | Segretario | Birch Cottage 1b Nursery Gardens BR7 5BW Chislehurst Kent | New Zealand | 71052900001 | ||||||
| VINCENT, Susan Jane | Segretario | 53 Cavendish Drive Hagley DY9 0LR Stourbridge Worcestershire | British | 95619190001 | ||||||
| BRADLEY, John | Amministratore | 8 Brackenwood Road Rooks Nest Outwood WF1 3TH Wakefield West Yorkshire | British | 51073960001 | ||||||
| BROWN, Denis James | Amministratore | 85 Grange Road NE61 2TS Morpeth Northumberland | British | 20169780001 | ||||||
| CANNING, David John | Amministratore | 24 Aldbourne Avenue RG6 2DB Earley Reading Berkshire | British | 36745230001 | ||||||
| CORR, Geoff | Amministratore | 20 Cotswold Drive CV3 6EY Coventry West Midlands | British | 20169800001 | ||||||
| DARLING, Stephen Lyon | Amministratore | Archway Cottage Yorton Heath SY4 3EU Shrewsbury | United Kingdom | British | 72268220001 | |||||
| DORMAN, Robert Malcolm | Amministratore | 210 Walsall Road Four Oaks B74 4QB Sutton Coldfield West Midlands | British | 40185340001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Amministratore | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Amministratore | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| HILDEBRANDT, Michael Leslie | Amministratore | Hafod Farm Gwaenysgor LL18 6EP Rhyl Flintshire | United Kingdom | British | 111294680001 | |||||
| HOOKWAY, David Wilfred | Amministratore | 68 Hartley Old Road CR8 4HJ Purley Surrey | British | 374710001 | ||||||
| JOHNSON, Peter | Amministratore | 54 Mymms Drive Brookmans Park AL9 7AF Hatfield Hertfordshire | British | 11342310001 | ||||||
| JONES, Anne Elizabeth | Amministratore | 9 The Terraces Garner Street E2 9AQ London | Great Britain | British | 32870900001 | |||||
| MARSHALL, Graeme Richard Dickson | Amministratore | 19 Marden Road Staplehurst TN12 0NF Tonbridge Kent | British | 42931720001 | ||||||
| MARSHALL, John Jeremy | Amministratore | Heathercroft 33 Bittell Road B45 8LU Barnt Green Worcestershire | United Kingdom | British | 141401190001 | |||||
| MCIVER, Michael James | Amministratore | Larkhill Farm Oxford Road CV23 9QE Princethorpe Warwickshire | British | 47658740001 | ||||||
| MITCHELHILL, Robert George | Amministratore | Brackenridge Bednall Head Stafford Staffs | British | 12614170001 | ||||||
| MORRIS, Michael Edward | Amministratore | Dingle Hill Hollybush HR8 1EX Ledbury Herefordshire | British | 20169820001 | ||||||
| OLLERTON, Susan | Amministratore | 5 Barbers Lane Catherine De Barnes B92 0DH Solihull West Midlands | British | 72001110002 | ||||||
| OSBALDSTONE, Albert Edward | Amministratore | 49 Woodlands Park Thornliebank G46 7RZ Glasgow Lanarkshire | British | 20169840001 | ||||||
| PARFITT, Alun James | Amministratore | River View Lodge Road Caerleon NP18 3QY Newport Gwent | United Kingdom | British | 56694170001 | |||||
| PYE, Derek | Amministratore | 134 Shevington Lane Shevington WN6 8BJ Wigan Lancashire | British | 34280980001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Amministratore | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Amministratore | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| SMITH, Martin Christopher Geoffrey | Amministratore | 9 Finlarigg Drive Edgbaston B15 3RH Birmingham West Midlands | England | British | 71281420001 | |||||
| TAPPIN, Reginald George Richard | Amministratore | Tudor Cottage 3 Dome Hill CR3 6EE Caterham Surrey | British | 2785080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KELNIGAL EUROPE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Nigel Stuart Bell | 06 apr 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Kelvin William Thomas Hingley | 06 apr 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
KELNIGAL EUROPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 22 apr 2013 Consegnato il 10 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high point rendel group PLC, vantagepoint management consultants (public sector) limited | Creato il 04 lug 2001 Consegnato il 24 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 09 ott 1995 Consegnato il 12 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 15 dic 1986 Consegnato il 05 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 lug 1982 Consegnato il 15 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0