THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED

THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01319819
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Two Snowhill
    Snow Hill
    B4 6GA Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMTRANS LIMITED01 lug 197701 lug 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL United Kingdom a Two Snowhill Snow Hill Birmingham West Midlands B4 6GA in data 26 mar 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 mar 2018

    LRESSP

    Cessazione della carica di Georgina Garratt come segretario in data 28 feb 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Georgina Garratt come amministratore in data 01 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Nomina di Ms Georgina Garratt come segretario in data 20 feb 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lyndsay Navid Lane come segretario in data 17 feb 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David James Thomas come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Gavin Evans come amministratore in data 04 nov 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2016

    Stato del capitale al 09 mag 2016

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Lyndsay Navid Lane il 09 mag 2016

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Nomina di Mr David James Thomas come amministratore in data 30 nov 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Patrick Bataillard come amministratore in data 27 nov 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gaultier De La Rochebrochard come amministratore in data 29 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 14 ott 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton Northamptonshire NN5 7SL a Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL in data 26 giu 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVANS, Simon Gavin
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    United KingdomBritish150758530001
    GARRATT, Georgina
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    United KingdomBritish242693040001
    GARRATT, Georgina
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Segretario
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    225097100001
    HORNE, Geoffrey Wemyss
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    British66121750001
    LYNCH, David Paul
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    British52425370006
    LYNCH, David Paul
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    British52425370002
    MCDONALD, Charles Malcolm
    11 Lennox Row
    EH5 3JP Edinburgh
    Scotland
    Segretario
    11 Lennox Row
    EH5 3JP Edinburgh
    Scotland
    British42547930001
    NAVID LANE, Lyndsay
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Segretario
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    British163252740001
    ROSE, Ian Andrew
    Trehern Close
    Knowle
    B93 9HA Solihull
    3
    West Midlands
    Segretario
    Trehern Close
    Knowle
    B93 9HA Solihull
    3
    West Midlands
    British128431040001
    ADAM, Ian C
    Gowanfield
    2 Cammo Road
    EH4 8EB Edinburgh
    Amministratore
    Gowanfield
    2 Cammo Road
    EH4 8EB Edinburgh
    ScotlandBritish37076220001
    ASPDEN, Peter Graham
    Sandholme
    Walton Road
    LE17 5RU Kimcote
    Leicestershire
    Amministratore
    Sandholme
    Walton Road
    LE17 5RU Kimcote
    Leicestershire
    EnglandBritish78527750003
    BATAILLARD, Patrick
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    FrenchFrench148397660002
    BRISTOW, David John
    12 Hillside Close
    Heddington
    SN11 0PZ Calne
    Wiltshire
    Amministratore
    12 Hillside Close
    Heddington
    SN11 0PZ Calne
    Wiltshire
    British72470990001
    DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier
    Nd House Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Nobert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Gb
    Amministratore
    Nd House Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Nobert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Gb
    FranceFrench163237590002
    HORNE, Geoffrey Wemyss
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish66121750001
    HOWES, David William
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    British53711750001
    HUTTON, Timothy Horace
    Highcroft Lodge Farm
    LE17 6NW Husbands Bosworth
    Leicestershire
    Amministratore
    Highcroft Lodge Farm
    LE17 6NW Husbands Bosworth
    Leicestershire
    British50886110001
    LANGLANDS, George Flockhart
    Badachro 5 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Badachro 5 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    British21371800001
    LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    FranceFrench126820460002
    LAVELLE, James William
    Meadow Court The Lane
    Grafton Regis
    NN12 7HW Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Meadow Court The Lane
    Grafton Regis
    NN12 7HW Towcester
    Northamptonshire
    British55957600002
    LYNCH, David Paul
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    British52425370002
    NAVID LANE, Lyndsay Gillian
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    EnglandBritish177674310001
    PEPPIATT, Edward Hugh Davidson
    Church Farm
    Oxendon Road, Arthingworth
    LE16 8LA Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Church Farm
    Oxendon Road, Arthingworth
    LE16 8LA Market Harborough
    Leicestershire
    British83323550001
    RUSCH, Henry
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    British63973770001
    THOMAS, David James
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    EnglandBritish147800590002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    06 apr 2016
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2832085
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Single debenture
    Creato il 24 apr 1991
    Consegnato il 30 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balance
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 24 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a rent guarantee dated 13/5/89 for £108070 given to legal and general and in relation to a kent guarantee dated 19/1/90 for £246.000 given to lazard property unit trust
    Brevi particolari
    The sum of £354,070 on an account numbered 7477813.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement entitted "prompt credit application"
    Creato il 06 nov 1990
    Consegnato il 13 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £197669-35 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse of the form 395, see doc for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 mag 1989
    Consegnato il 02 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A charge by way of legal mortgage over freehold land k/a land at amberley way west side of gren lane heston title no. Ngl 460967 and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1989
    Consegnato il 18 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h land k/a unit 6, block c, winneral tnangle wokingham, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 feb 1985
    Consegnato il 14 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - land at cutbush close, earley, leading, berks & land on the south east side of cutbush lane, ealey, reading, berks,. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1983
    Consegnato il 05 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a land at amberley way, west side of green lane, heston, london borough of hounslow, (formerly park tn: mx 316152). together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 apr 1983
    Consegnato il 29 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1983Registrazione di un'ipoteca

    THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 mar 2018Inizio della liquidazione
    05 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0