THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01319819 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Two Snowhill Snow Hill B4 6GA Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COMTRANS LIMITED | 01 lug 1977 | 01 lug 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL United Kingdom a Two Snowhill Snow Hill Birmingham West Midlands B4 6GA in data 26 mar 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Georgina Garratt come segretario in data 28 feb 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Ms Georgina Garratt come amministratore in data 01 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Georgina Garratt come segretario in data 20 feb 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lyndsay Navid Lane come segretario in data 17 feb 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Thomas come amministratore in data 04 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Gavin Evans come amministratore in data 04 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lyndsay Navid Lane il 09 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David James Thomas come amministratore in data 30 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Bataillard come amministratore in data 27 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gaultier De La Rochebrochard come amministratore in data 29 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 14 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton Northamptonshire NN5 7SL a Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL in data 26 giu 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Simon Gavin | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 150758530001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 242693040001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | 225097100001 | |||||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Segretario | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | British | 66121750001 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | British | 52425370006 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Segretario | 14 Douglas Road NN5 6XX Northampton Northamptonshire | British | 52425370002 | ||||||
| MCDONALD, Charles Malcolm | Segretario | 11 Lennox Row EH5 3JP Edinburgh Scotland | British | 42547930001 | ||||||
| NAVID LANE, Lyndsay | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | British | 163252740001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Segretario | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | British | 128431040001 | ||||||
| ADAM, Ian C | Amministratore | Gowanfield 2 Cammo Road EH4 8EB Edinburgh | Scotland | British | 37076220001 | |||||
| ASPDEN, Peter Graham | Amministratore | Sandholme Walton Road LE17 5RU Kimcote Leicestershire | England | British | 78527750003 | |||||
| BATAILLARD, Patrick | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | French | French | 148397660002 | |||||
| BRISTOW, David John | Amministratore | 12 Hillside Close Heddington SN11 0PZ Calne Wiltshire | British | 72470990001 | ||||||
| DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier | Amministratore | Nd House Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Nobert Dentressangle House Northamptonshire Gb | France | French | 163237590002 | |||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Amministratore | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 66121750001 | |||||
| HOWES, David William | Amministratore | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||
| HUTTON, Timothy Horace | Amministratore | Highcroft Lodge Farm LE17 6NW Husbands Bosworth Leicestershire | British | 50886110001 | ||||||
| LANGLANDS, George Flockhart | Amministratore | Badachro 5 Highfield Gardens WS14 9JA Lichfield Staffordshire | British | 21371800001 | ||||||
| LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 126820460002 | |||||
| LAVELLE, James William | Amministratore | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Amministratore | 14 Douglas Road NN5 6XX Northampton Northamptonshire | British | 52425370002 | ||||||
| NAVID LANE, Lyndsay Gillian | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 177674310001 | |||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Amministratore | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| RUSCH, Henry | Amministratore | Victoria House 161 Station Road LE9 7GF Earl Shilton Leicestershire England | British | 63973770001 | ||||||
| THOMAS, David James | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 147800590002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpo Holdings Uk And Ireland Limited | 06 apr 2016 | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Creato il 24 apr 1991 Consegnato il 30 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balance | Creato il 16 apr 1991 Consegnato il 24 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a rent guarantee dated 13/5/89 for £108070 given to legal and general and in relation to a kent guarantee dated 19/1/90 for £246.000 given to lazard property unit trust | |
Brevi particolari The sum of £354,070 on an account numbered 7477813. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement entitted "prompt credit application" | Creato il 06 nov 1990 Consegnato il 13 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £197669-35 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Brevi particolari All right title and interest of the company in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse of the form 395, see doc for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 15 mag 1989 Consegnato il 02 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A charge by way of legal mortgage over freehold land k/a land at amberley way west side of gren lane heston title no. Ngl 460967 and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 feb 1989 Consegnato il 18 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h land k/a unit 6, block c, winneral tnangle wokingham, berkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 feb 1985 Consegnato il 14 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H - land at cutbush close, earley, leading, berks & land on the south east side of cutbush lane, ealey, reading, berks,. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1983 Consegnato il 05 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land k/a land at amberley way, west side of green lane, heston, london borough of hounslow, (formerly park tn: mx 316152). together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 apr 1983 Consegnato il 29 apr 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0