HARGREAVES VENDING LIMITED

HARGREAVES VENDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARGREAVES VENDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01322308
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARGREAVES VENDING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mccoll's House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 nov 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Bernadette Clare Young come segretario in data 07 set 2018

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 nov 2016

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Steven Green come amministratore in data 22 ago 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Bernadette Clare Young come segretario in data 22 ago 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Jonathan Miller come segretario in data 22 ago 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 nov 2015

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Jeremy Ian Fuller come amministratore in data 26 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Lancaster come amministratore in data 26 apr 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2016

    Stato del capitale al 07 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2014

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Kingsley John Tedder come segretario in data 12 ago 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 nov 2013

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Martyn James Aguss come amministratore in data 30 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2014

    Stato del capitale al 12 giu 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Martin Mccoll House Ashwells Road Pilgrims Hatch Brentwood Essex CM15 9ST* in data 21 gen 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 nov 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 nov 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish181763320001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish209349290001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish88269280005
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Segretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Segretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Segretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237612690001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish107991420002
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Amministratore
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    FOSTER, Brian
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    British24323870001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish147052660001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Amministratore
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    POPE, Philip
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    Amministratore
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish52431400001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish101631100002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    06 apr 2016
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03462566
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HARGREAVES VENDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 nov 1998
    Consegnato il 08 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 31 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 1984
    Consegnato il 01 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land with the buildings erected thereon situate at and known as 146 manchester road droylsden, tameside, greater manchester.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1983
    Consegnato il 13 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land on the north side of manchester road, droylsden, tameside, greater manchester title no. La 316784 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1983
    Consegnato il 13 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land and buildings on the south side of manor road, droylsden tameside, greater manchester. Title no p 178345 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed supplemental to a debenture
    Creato il 17 ago 1981
    Consegnato il 21 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23.10.79
    Brevi particolari
    Fixed charge on all bookdebts & other debts of the company both present & future.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 lug 1981
    Consegnato il 16 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate on the east side of hemmons road now known as unit 1 longden road longsight. Manchester greater manchester title no: gm 229537 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 1979
    Consegnato il 01 nov 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All fixtures, fittings fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited.
    Transazioni
    • 01 nov 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1979
    Consegnato il 21 mag 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H known as 35 longshut lane west stockport greater manchester title number ch 70634 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transazioni
    • 21 mag 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0