BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED

BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01322680
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oxford Chambers Oxford Road
    Guiseley
    LS20 9AT Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J SAINSBURY DEVELOPMENTS LIMITED21 gen 199321 gen 1993
    J SAINSBURY (FARMS) LIMITED22 lug 197722 lug 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    22 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 mag 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da 33 Cavendish Square London W1G 0PW a Oxford Chambers Oxford Road Guiseley Leeds LS20 9AT in data 07 set 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ago 2015

    Stato del capitale al 27 ago 2015

    • Capitale: GBP 101
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 25 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP 101
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 25 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ago 2013

    Stato del capitale al 29 ago 2013

    • Capitale: GBP 101
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 25 mar 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 25 mar 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 25 mar 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 11Th Floor East 33 Cavendish Square London W1G 0PW* in data 06 set 2010

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 dic 2009

    • Capitale: GBP 101
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Julian Ralph Stewart Newiss come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Christakis Christofi come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Guy Ian Swinburn Wilson come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHRISTOFI, Christakis
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    Segretario
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    British147953920001
    NEWISS, Julian Ralph Stewart
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    Amministratore
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    EnglandBritishCompany Director25776880001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    Amministratore
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    EnglandBritishCompany Director141163410001
    ASHFORD, Elisabeth Ann
    10 Frankland Crescent
    Lower Parkstone
    BH14 9PX Poole
    Dorset
    Segretario
    10 Frankland Crescent
    Lower Parkstone
    BH14 9PX Poole
    Dorset
    BritishCompany Secretary40242580001
    BISHOP, Leonard Charles
    Hollybank Turners Green Lane
    Sparrows Green
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    Segretario
    Hollybank Turners Green Lane
    Sparrows Green
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    British30396230001
    HAMILTON, William
    10 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    10 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British34584510001
    JARVIS, Hazel Debra
    112 Wickham Street
    DA16 3LU Welling
    Kent
    Segretario
    112 Wickham Street
    DA16 3LU Welling
    Kent
    British69063710002
    KERSHAW, Philip
    27 Burrow Road
    St Francis Place
    SE22 8DU East Dulwich
    London
    Segretario
    27 Burrow Road
    St Francis Place
    SE22 8DU East Dulwich
    London
    British47163580002
    LEES, Roger Alan
    Redstack
    58 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ Croydon
    Surrey
    Segretario
    Redstack
    58 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ Croydon
    Surrey
    BritishChartered Accountant82020840001
    AITCHISON, Gordon Clark
    36 Sauncey Avenue
    AL5 4QJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    36 Sauncey Avenue
    AL5 4QJ Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor146947440001
    ANDERSON, Robin Andrew
    3 Garston Park
    RH9 8NE Godstone
    Surrey
    Amministratore
    3 Garston Park
    RH9 8NE Godstone
    Surrey
    BritishChartered Surveyor14893770001
    BAKER, Trevor Anthony
    Lime Tree Cottage
    145 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Lime Tree Cottage
    145 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor105145410001
    BAKER, Trevor Anthony
    Lime Tree Cottage
    145 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Lime Tree Cottage
    145 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor105145410001
    BENNETT, Nigel Alexander Ody
    Flat 2
    60 Salford Road
    SW2 4BG London
    Amministratore
    Flat 2
    60 Salford Road
    SW2 4BG London
    EnglandBritishFund Manager40430460001
    CHADWICK, Richard Andrew
    13 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    Amministratore
    13 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    EnglandBritishChartered Accountant23417870001
    COULL, Ian David
    3, The Woodlands
    Penn
    HP10 8JD High Wycombe
    Sleepy Hollow
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    3, The Woodlands
    Penn
    HP10 8JD High Wycombe
    Sleepy Hollow
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector140437190001
    FROUD, Jolyon Charles Edward
    20 Wingate Road
    Hammersmith
    W6 0UR London
    Amministratore
    20 Wingate Road
    Hammersmith
    W6 0UR London
    United KingdomBritishChartered Surveyor94098210001
    FRY, Alec Walter
    May Cottage Petersfield Road
    Ropley
    SO24 0EQ Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    May Cottage Petersfield Road
    Ropley
    SO24 0EQ Alresford
    Hampshire
    BritishChief Accountant27618500001
    HAMILTON, William
    10 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    10 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary34584510001
    HENDERSON, Barry
    54 Quinta Drive
    EN5 3AY Arkley
    Hertfordshire
    Amministratore
    54 Quinta Drive
    EN5 3AY Arkley
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor34537900001
    LEES, Roger Alan
    Redstack
    58 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Redstack
    58 Sanderstead Court Avenue
    CR2 9AJ Croydon
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant82020840001
    MALLETT, Richard Finer
    47 Common Close
    GU21 4DB Woking
    Surrey
    Amministratore
    47 Common Close
    GU21 4DB Woking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant54631210001
    MATTHEWS, Nigel Frederick
    22 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary2001550001
    MONAGHAN, Philip
    49 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Amministratore
    49 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    BritishProperty Development48903220001
    PETIT, James William
    71 Wandworth Common
    Westside
    SW18 2ED London
    Amministratore
    71 Wandworth Common
    Westside
    SW18 2ED London
    EnglandBritishFund Manager52473820001
    ROBERTS, David Norton
    31 Beeches Walk
    SM5 4JS Carshalton
    Surrey
    Amministratore
    31 Beeches Walk
    SM5 4JS Carshalton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Treasurer124027930001
    SAUNDERS, Gary Edward
    16 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    16 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishPerformance Director64191540001
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishProperty Director215884620001
    TOWNSEND, Jeremy Charles Douglas
    Wild Wood
    8 Bird In Hand Lane
    BR1 2NB Bromley
    Kent
    Amministratore
    Wild Wood
    8 Bird In Hand Lane
    BR1 2NB Bromley
    Kent
    EnglandBritishAccountant106408890001
    WEBSTER, Simon Lee
    Ray Park Lodge
    57 Ray Park Avenue
    SL6 8DZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Ray Park Lodge
    57 Ray Park Avenue
    SL6 8DZ Maidenhead
    Berkshire
    BritishDept Director Planning & Dev78991460001

    BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over account
    Creato il 24 ott 2008
    Consegnato il 31 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full guarantee, charges all its right, title and interest, present and future, in the account and the deposit to the lender by way of first fixed charge. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignation in security
    Creato il 27 nov 2003
    Consegnato il 16 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's whole rights and benefit in and to the letter of intent; the buildings contract; and rights of the company relative to the letter of intent and the building contract.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 nov 2003
    Consegnato il 15 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bretton centre bretton peterborough f/h land with title absolute t/n CB178992, l/h land with title absolute t/n CB257818, (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 8TH december december 2003 and
    Creato il 27 nov 2003
    Consegnato il 16 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole those subjects on the south east side of union street and the north east side of market street aberdeen t/n ABN63261.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security presented for registration in scotland on 17 february 2003 and
    Creato il 30 gen 2003
    Consegnato il 20 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    7
    Brevi particolari
    All and whold the subjects known as cuckoo bridge retail park dumfries t/n DMF6641 & DMF6871.
    Persone aventi diritto
    • Philtor Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 22 january 2003 and
    Creato il 09 gen 2003
    Consegnato il 28 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a union street market street adelphi afelphi court adelphi lane and carnegie's brae aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Dawn Developments Limited
    Transazioni
    • 28 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLUE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 ott 2016Data di scioglimento
    21 mag 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kate E Breese
    Oxford Chambers Oxford Road
    Guiseley
    LS20 9AT Leeds
    Praticante
    Oxford Chambers Oxford Road
    Guiseley
    LS20 9AT Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0