GROUP AIR REALISATIONS LIMITED

GROUP AIR REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGROUP AIR REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01329030
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    • Attività dei tour operator (79120) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAGE & MOY TRAVEL GROUP AIR HOLIDAYS LIMITED04 mar 201104 mar 2011
    TRAVELSPHERE LIMITED08 ott 198608 ott 1986
    TRAVELSPHERE (HARBOROUGH) LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    AWNMAY TRANSPORT LIMITED07 set 197707 set 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form WU09 - secretary of state's release
    3 pagineLIQ MISC

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    11 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    41 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    38 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    21 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    48 pagine2.17B

    Risultato della riunione dei creditori

    50 pagine2.23B

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 20 gen 2017

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 16 gen 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 dic 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 013290300020 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 013290300021, creata il 09 dic 2016

    20 pagineMR01

    Cessazione della carica di Nigel John Arthur come segretario in data 27 set 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Peter Eric Buckley come segretario in data 27 set 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel John Arthur come amministratore in data 27 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2015

    29 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 013290300020, creata il 04 mag 2016

    21 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUCKLEY, Peter Eric
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Segretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    215220310001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomEnglish81122260002
    MCKINNON, Tracey Anne
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927400001
    SMITH, Ian
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish5734800003
    WILSON, Colin James
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927160001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    193406110001
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Segretario
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    GADSBY, Christopher
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    161968570001
    HARDMAN, John Benjamin
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131024350001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Segretario
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    British125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    British59274640002
    WITTS, Kevan
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    190942650001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandEnglish175689210001
    AUSTEN, Belinda Jane
    28 Stockerston Road
    LE15 9UD Uppingham
    Leicestershire
    Amministratore
    28 Stockerston Road
    LE15 9UD Uppingham
    Leicestershire
    British102336650001
    BRYANT, Robert David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish152320790001
    BURTON, William John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish64885440001
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    COE, Albert Henry
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    Amministratore
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    United KingdomBritish3977310002
    DUFTY, Andrew
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish161857980002
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Amministratore
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    GADSBY, Christopher James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish118396090002
    GOODENOUGH, Steven
    61 Northampton Road
    LE16 9HD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    61 Northampton Road
    LE16 9HD Market Harborough
    Leicestershire
    British54620130001
    HARVEY, Gillian
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140490960002
    HIGMAN, Mark
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140504540003
    MACKAY, Richard
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    British26236830001
    MORRIS, Neil John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish158818060001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Amministratore
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    PHILPOT, Nathan Richard
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    UkBritish160975710001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish125431690001
    SPRIGGS, Pauline Ann
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    Amministratore
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    United KingdomBritish47259460001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish59274640002
    WAKE, Bruce Hereward
    Hall Cottage
    Ayston
    LE15 Uppingham
    Leicestershire
    Amministratore
    Hall Cottage
    Ayston
    LE15 Uppingham
    Leicestershire
    British26236840001
    WATTS, Mark Bingham Titus
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    Amministratore
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    United KingdomBritish43948350004

    GROUP AIR REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 dic 2016
    Consegnato il 13 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Land lying to the north west of rockingham road, market harborough (LT282958); land at rockingham road, market harborough (LT359863); and compass house, rockingham road, market harborough, LE16 7QD (LT230882).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • All Leisure Holidays Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 mag 2016
    Consegnato il 06 mag 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold land known as compass house, rockingham road, market harborough, leicestershire, LE16 7QD (title numbers LT230882, LT282958 and LT359863).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over offset bank account
    Creato il 02 mag 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All security interest and dispositions, all monies at any time standing to the credit of the security account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over offset bank account
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 14 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any member of the group to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right, title and interest in to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 14 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 09 set 1997
    Consegnato il 19 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account no.24705422. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 15 apr 1996
    Consegnato il 18 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: travelsphere limited gts treasurers deposit bid no. 73502077 and (b) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesiad, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the "deposit(s)" together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 27 feb 1995
    Consegnato il 03 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge over all the deposit(s) together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 26 lug 1994
    Consegnato il 02 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the "deposit(s)" together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged contract(s)-barclays bank PLC re travelsphere limited G.T.S. dib deposit deal no. 75755677 (*charge reinstated pursuant to an order of court dated 10 june 1997 together with the variation order). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer deed .
    Creato il 01 set 1993
    Consegnato il 16 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being the three swans hotel, high street, market harborough, leicestershire , title no lt 192973 ,together with all buildings ,fixtures, and fixed plant and machinery, from time to time in or on any real property charged.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 mar 1990
    Consegnato il 26 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and/or l/h hereditaments & premises situate at rockingham road, ,market harborough, leicestershire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1990
    Consegnato il 26 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 13 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 10 fairfield road market, harborough, leicestershire together with the fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 13 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 21 fairfield road market harborough, leicestershire together with fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank LTD
    Transazioni
    • 13 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 13 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 16 fairfield road market harborough, leicestershire together with the fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 25 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold the three swans hotel high street market harborough leicestershire with fixed plant machinery & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 25 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 apr 1986
    Consegnato il 11 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold compass house coventry road, market harborough, leicester LE18 9BZ. All fixed plant machinery and other fixtures.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 11 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 08 mag 1985
    Consegnato il 20 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account (s) of the company with the banks designated bid deposits.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1984
    Consegnato il 09 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 34 coventry road, market harborough, leicestershire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1984
    Consegnato il 09 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 1, 3 and 6 school lane market harborough, leicestershire. & land to the rear of 36 & 38 coventry road, aforesaid.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mar 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GROUP AIR REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 dic 2016Inizio dell'amministrazione
    22 mag 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    22 mag 2018Inizio della liquidazione
    01 nov 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Dunckley
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0