BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED

BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01329536
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • (1587) /

    Dove si trova BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bakkavor
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WINE AND DINE COMPANY LIMITED12 set 197712 set 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2010

    11 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Jonathan Jowett come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Sunita Kaushal come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2010

    Stato del capitale al 28 gen 2010

    • Capitale: GBP 2,359,667
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 29 dic 2007

    23 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 dic 2006

    29 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KAUSHAL, Sunita
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Bakkavor
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Segretario
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Bakkavor
    Lincolnshire
    United Kingdom
    150195880001
    GUDMUNDSSON, Agust
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    Amministratore
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    United KingdomIcelandicCompany Director79348500004
    HOWES, Richard David
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director118715250001
    DURRANT, Dawn Elizabeth
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    Segretario
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    BritishCompany Secretary47940000002
    JOWETT, Jonathan David
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Segretario
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    BritishSolicitor103825760001
    MICHAEL, Wollaston
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    Warwickshire
    BritishFinancial Director81737230001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Segretario
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    BritishFinancial Controller151217690001
    THOMAS, Lindy Patricia
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    British22536820001
    WOLLASTON, Michael
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    Segretario
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    British55994760002
    BERRY, Helen
    Mimosa Cottage 25 Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8NN Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Mimosa Cottage 25 Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8NN Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director13895110002
    CONSTANTINE, Savvas
    9 Birch Hollow
    Edgbaston
    B15 2QE Birmingham
    Amministratore
    9 Birch Hollow
    Edgbaston
    B15 2QE Birmingham
    EnglandCypriotCompany Director74009990001
    DAWES, Howard Anthony Leigh
    Craycombe House Evesham Road
    Fladbury
    WR10 2QS Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Craycombe House Evesham Road
    Fladbury
    WR10 2QS Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritishChartered Accountant29228990001
    DURRANT, Dawn Elizabeth
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Secretary47940000002
    GUDMUNDSSON, Agust
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    Amministratore
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    United KingdomIcelandicDirector79348500004
    GUDMUNDSSON, Lydur
    68 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    Amministratore
    68 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    EnglandIcelandicDirector113042340001
    JOSEPH, Charles Simon
    Brookfield Manor Lane
    Baydon
    SN8 2JD Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Brookfield Manor Lane
    Baydon
    SN8 2JD Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director42256050002
    LARGE, Paul Raymond
    85 Sandcliffe Road
    Midway
    DE11 7PJ Swadlincote
    Derbyshire
    Amministratore
    85 Sandcliffe Road
    Midway
    DE11 7PJ Swadlincote
    Derbyshire
    BritishManaging Director70852870001
    MELVILLE, Robert
    8 Thirlmere Gardens
    LE65 1FN Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Thirlmere Gardens
    LE65 1FN Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    EnglandBritishOperations Director96604770001
    MICHAEL, Wollaston
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    Warwickshire
    Amministratore
    18 Floyd Grove
    Balsall Common
    CV7 7RP Coventry
    Warwickshire
    BritishFinancial Director81737230001
    NISBETT, Andrew Joseph
    254a Birmingham Road
    Wylde Green
    B72 1DH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    254a Birmingham Road
    Wylde Green
    B72 1DH Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishIt And Purchasing Director81958500002
    PULLEN, Jonathan Mark
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishGroup Finance Director38923660001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Amministratore
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller151217690001
    SCHWALOWSKY MONKS, Jeremy Peter
    13 High Street
    New Whittington
    S43 2DX Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    13 High Street
    New Whittington
    S43 2DX Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishTechnical Director66753510001
    SLEGG, Michael John
    24 Naish Road
    BH25 7PU Barton On Sea
    Hampshire
    Amministratore
    24 Naish Road
    BH25 7PU Barton On Sea
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director76666700003
    THOMAS, Lindy Patricia
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector22536820001
    VOYLE, Gareth John
    6 Northfield Court
    Conduit Street
    PE9 1RA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    6 Northfield Court
    Conduit Street
    PE9 1RA Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChief Executive Office69027440005
    ZACHARIADES, Kikis Costa
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector24090910001
    ZACHARIADES, Maria Kikis
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    13 Charlotte Road
    Edgbaston
    B15 2NG Birmingham
    West Midlands
    BritishProject Manager48968770001

    BAKKAVOR (BIRMINGHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 24 mag 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings at 30-34 86 and 87 carver street and land to the east of carver street hockley birmingham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mag 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Agent
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 2000
    Consegnato il 01 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    30-34 carver street birmingham west midlands t/n WM499950. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 04 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 87 carver street birmingham west midlands.t/no WM523418.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 03 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 86 carver street, hockley, birmingham, west midlands t/nos. WM326902 and WM449740 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 15 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property and land adjacent to 86 carver street hockley birmingham and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 1990
    Consegnato il 21 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1988
    Consegnato il 30 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 86 cavuer street birmingham, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 30 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mag 1988
    Consegnato il 31 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade & tenant's fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 1985
    Consegnato il 02 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    226, monument road, edgbaston, birimigham (l/h).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Banco Exterior - UK.
    Transazioni
    • 02 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 mag 1984
    Consegnato il 30 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Banco Exterior - UK.
    Transazioni
    • 30 mag 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0