VICTOR GROUP LIMITED

VICTOR GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVICTOR GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01330212
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VICTOR GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VICTOR GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cala House
    54 The Causeway
    TW18 3AX Staines
    Surrey
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VICTOR GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VICTOR HOMES LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    VICTOR SYSTEM HOMES LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    WULEIGH LIMITED15 set 197715 set 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di VICTOR GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per VICTOR GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2013

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 apr 2013

    7 pagine4.68

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 apr 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 18 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2012

    Stato del capitale al 24 apr 2012

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Block B Burgan House the Causeway Staines Middlesex TW18 3PR in data 02 mar 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    5 pagineAA

    legacy

    15 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 18 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    5 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Alan Downie come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Ball come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan Duke Brown come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    7 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di VICTOR GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    BROWN, Alan Duke
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    Amministratore
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    EnglandBritish32640750005
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Amministratore
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54537790003
    WARD, Arnold Geoffrey
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    British7510670001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BALL, Geoffrey Arthur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Amministratore
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish246030002
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Amministratore
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    DOWNIE, Alan Wood
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Amministratore
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish248110001
    EAMES, Malcolm Russell
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    British26059770001
    FLEMING, Peter Maclean
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish43012300001
    KENT, Kathleen
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    British7510700001
    MORE, Gerald Campbell
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    Amministratore
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    British66976580001
    PRESTON, James Jackson Wilson
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    British57938300004
    WILLETTS, Franklyn Nigel
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26059780002

    VICTOR GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 giu 2010
    Consegnato il 07 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC ( the “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 07 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 21 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of charge
    Creato il 08 lug 1994
    Consegnato il 20 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from victor group limited to the governor and company of the bank of scotland under or pursuant to the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All monies now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books,.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 20 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 26 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 woodside road boston spa wetherby west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Building Society
    Transazioni
    • 26 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 26 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 applerley lane yeadon wst yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Building Society
    Transazioni
    • 26 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 26 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 bolehill park brighouse west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Building Society
    Transazioni
    • 26 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 26 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    22 george lane calverton nottingham.
    Persone aventi diritto
    • National & Provincial Building Society
    Transazioni
    • 26 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 26 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    23 oakwell avenue batley west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • National & Provincial Building Society
    Transazioni
    • 26 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 23 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge not exceeding £1,000,000.
    Brevi particolari
    Any properties purchased by the company in part exchange for new properties sold out.
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Building Society
    Transazioni
    • 23 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 1990
    Consegnato il 17 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land fronting hall lane northawram hall halifax west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land on the north side of abbotsford road york north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land on north side of intake place bromley west yorkshire title no wyk 422779.
    Persone aventi diritto
    • The Governor Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land in the north east side of fieldhead lane and birstall lane droghlington leeds w yorkshire title no wyk 354895.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    9, 11 and 13 hyde terrace leeds together with lind & buildings lying to the west side of hyde place leeds w yorkshire title no:- wyk 418184 wyk 4181848 wyk 418185, wyk 4300778.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Providence works marsh pudsey w yorkshire title no 408594.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1989
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land lying to the smith of brownhill rd and on the east side of quarry lane and on the north of norwood drive birstall w yorkshire title no wyk 334272.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 25 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at rear of oaks cottage boston spa west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge registered pursuant to an order of court 17/8/89
    Creato il 26 gen 1989
    Consegnato il 30 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that f/h plot of land situate to the rear of oaks cottage oaks lane boston spa west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1988
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All those two, plots of land at laven thorpe lane thornton bradford w yorkshire title no:- wyk 420635.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1988
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Firstly willow cottage willow lane clifford west yorkshire secondly land comprising part of the croft albion street clifford west yorkshire title no wyk 335345.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1988
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    East cottingworth arms (formerly k/a the bluebell inn) east cottingwith humberside title no hs 29802.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1988
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or all of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Berkeley house, clarendon rd, leeds, west yorkshire title no ywe 54478 wnd WK419864.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 nov 1988
    Consegnato il 02 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at fieldhead lane, drighlington, leeds. The borrower as beneficial owner hereby charges by way of legal mortgage all and singular the above property together with all fixtures other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1988
    Consegnato il 24 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings a north side of abbotsford road york north yorkshire together with all fixtures whatseover now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transazioni
    • 24 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VICTOR GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 ott 2013Data di scioglimento
    19 apr 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Donald Mckinnon
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    Praticante
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0