INSTORE RETAILING LIMITED

INSTORE RETAILING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINSTORE RETAILING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01330505
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INSTORE RETAILING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INSTORE RETAILING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trident Business Park
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INSTORE RETAILING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POUNDSTRETCHER STORES LIMITED09 ago 199409 ago 1994
    LORIEN LABORATORIES LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    LALKNOLL LIMITED19 set 197719 set 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di INSTORE RETAILING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per INSTORE RETAILING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 ago 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Hemant Patel come amministratore in data 27 nov 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian York come amministratore in data 27 nov 2015

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2015

    Stato del capitale al 19 nov 2015

    • Capitale: GBP 11,100
    SH01

    Nomina di Ian York come amministratore in data 25 mar 2015

    AP01

    Cessazione della carica di Roy George Ellis come amministratore in data 25 mar 2015

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 ott 2014

    Stato del capitale al 13 ott 2014

    • Capitale: GBP 11,100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2013

    Stato del capitale al 19 nov 2013

    • Capitale: GBP 11,100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Abdul Aziz Tayub il 23 mag 2013

    3 pagineCH01

    Nomina di Mr Roy George Ellis come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ebrahim Suleman come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di INSTORE RETAILING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINSON, Martin Donald
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    Segretario
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    British98796330005
    PATEL, Hemant
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish104124100001
    TAYUB, Abdul Aziz
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish16280660001
    KEMP, Helen Anne
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    British48922660002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Segretario
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    LETHAM, Ian Ritchie
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Segretario
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British9252900001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SISSON, Hamish Paul
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    British43874820001
    BOYLE, Gerard
    4 St Michaels Way
    Addingham
    LS29 0RN Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 St Michaels Way
    Addingham
    LS29 0RN Ilkley
    West Yorkshire
    British4145070001
    BROWN, Gary James
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    Amministratore
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    EnglandBritish125196870001
    BURDON, Peter
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    Amministratore
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    British70178470002
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Roy George
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish161784490001
    GRAY, Ian
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    British50246030002
    HAMILTON, Lillias
    44 Hirstlands Drive
    WF5 8EJ Ossett
    West Yorkshire
    Amministratore
    44 Hirstlands Drive
    WF5 8EJ Ossett
    West Yorkshire
    British3612220001
    HAUGHTON, Townsend Andrew
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    South Africa39356840002
    HOYLE, Sally Elizabeth
    Millstones The Carriage Drive
    Milner Lane Greetland
    HX4 8HW Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Millstones The Carriage Drive
    Milner Lane Greetland
    HX4 8HW Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish101992720001
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    MAYNARD, Christopher Roland
    14 St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    14 St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    British94158510001
    RALPH, Francis John Haley
    49 Alms Hill Road
    Ecclesall
    S11 9RR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    49 Alms Hill Road
    Ecclesall
    S11 9RR Sheffield
    South Yorkshire
    British42579280001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Amministratore
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    SULEMAN, Ebrahim
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    EnglandBritish52733940001
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South African51820380002
    YORK, Ian
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish197002910001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INSTORE RETAILING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Instore Limited
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    England
    06 apr 2016
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione00347453
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    INSTORE RETAILING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 mar 1996
    Consegnato il 15 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nedcor Bank Limited as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 15 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 15 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 15 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 10 gen 1992
    Consegnato il 24 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise
    Brevi particolari
    See form 395 ref M19C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcthe "Security Agent" and the "Banks"
    Transazioni
    • 24 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 03 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all goodwill & uncalled capital. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 mar 1989
    Consegnato il 14 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 01 lug 1982
    Consegnato il 20 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies deed or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23/2/78
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book & other debts.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0