INSTORE RETAILING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INSTORE RETAILING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01330505 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INSTORE RETAILING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova INSTORE RETAILING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Trident Business Park Leeds Road HD2 1UA Huddersfield |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INSTORE RETAILING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| POUNDSTRETCHER STORES LIMITED | 09 ago 1994 | 09 ago 1994 |
| LORIEN LABORATORIES LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
| LALKNOLL LIMITED | 19 set 1977 | 19 set 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INSTORE RETAILING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per INSTORE RETAILING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 ago 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Hemant Patel come amministratore in data 27 nov 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian York come amministratore in data 27 nov 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Ian York come amministratore in data 25 mar 2015 | AP01 | |||||||||||
Cessazione della carica di Roy George Ellis come amministratore in data 25 mar 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Abdul Aziz Tayub il 23 mag 2013 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Roy George Ellis come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ebrahim Suleman come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di INSTORE RETAILING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINSON, Martin Donald | Segretario | 1 Badger Gate Meltham HD9 5LB Holmfirth | British | 98796330005 | ||||||
| PATEL, Hemant | Amministratore | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 104124100001 | |||||
| TAYUB, Abdul Aziz | Amministratore | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 16280660001 | |||||
| KEMP, Helen Anne | Segretario | 5 Birch Mews Oaklands Manor Long Causeway Adel LS16 8NX Leeds West Yorkshire | British | 48922660002 | ||||||
| KERRISON, Michael Arthur | Segretario | 57 Welldon Crescent HA1 1QP Harrow Middlesex | British | 1452630001 | ||||||
| LETHAM, Ian Ritchie | Segretario | 45 Palin Wood Road Delph OL3 5UW Oldham Lancashire | British | 9252900001 | ||||||
| ROELOFSE, Hendrik | Segretario | 18 Woodlands Green HG2 8QD Harrogate North Yorkshire | South African | 40527920003 | ||||||
| SISSON, Hamish Paul | Segretario | 20 Park View Court 29 Street Lane LS8 1BS Leeds West Yorkshire | British | 43874820001 | ||||||
| BOYLE, Gerard | Amministratore | 4 St Michaels Way Addingham LS29 0RN Ilkley West Yorkshire | British | 4145070001 | ||||||
| BROWN, Gary James | Amministratore | 3 Dewberry Fields Upholland WN8 0BQ Skelmersdale Lancashire | England | British | 125196870001 | |||||
| BURDON, Peter | Amministratore | 40 Firs Road Edwalton NG12 4BX Nottingham | British | 70178470002 | ||||||
| CLARKE, Paul | Amministratore | 74 Barons Close Kirby Muxloe LE9 2BW Leicester Leicestershire | British | 103719400001 | ||||||
| ELLIS, Robert Keith | Amministratore | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| ELLIS, Roy George | Amministratore | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | Wales | British | 161784490001 | |||||
| GRAY, Ian | Amministratore | Flat 48 Langtons Wharf LS2 7EN Leeds Yorkshire | British | 50246030002 | ||||||
| HAMILTON, Lillias | Amministratore | 44 Hirstlands Drive WF5 8EJ Ossett West Yorkshire | British | 3612220001 | ||||||
| HAUGHTON, Townsend Andrew | Amministratore | Staddlestones 11 Oakdale Manor HG1 2NA Harrogate North Yorkshire | South Africa | 39356840002 | ||||||
| HOYLE, Sally Elizabeth | Amministratore | Millstones The Carriage Drive Milner Lane Greetland HX4 8HW Halifax West Yorkshire | England | British | 101992720001 | |||||
| KERRISON, Michael Arthur | Amministratore | 57 Welldon Crescent HA1 1QP Harrow Middlesex | British | 1452630001 | ||||||
| MAYNARD, Christopher Roland | Amministratore | 14 St Winifreds Road HG2 8LN Harrogate North Yorkshire | British | 94158510001 | ||||||
| RALPH, Francis John Haley | Amministratore | 49 Alms Hill Road Ecclesall S11 9RR Sheffield South Yorkshire | British | 42579280001 | ||||||
| ROELOFSE, Hendrik | Amministratore | 18 Woodlands Green HG2 8QD Harrogate North Yorkshire | South African | 40527920003 | ||||||
| SMITH, Martin Freeman | Amministratore | 84 Pendle Gardens Culcheth WA3 4LU Warrington | British | 44140230002 | ||||||
| SULEMAN, Ebrahim | Amministratore | 8 St Marys Avenue WF17 7PT Batley West Yorkshire | England | British | 52733940001 | |||||
| VISSER, Johan Jacobus | Amministratore | 22 Mackenzie Gardens East Kilbride G74 4SA Glasgow Lanarkshire | South African | 51820380002 | ||||||
| YORK, Ian | Amministratore | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 197002910001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INSTORE RETAILING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instore Limited | 06 apr 2016 | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
INSTORE RETAILING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 28 mar 1996 Consegnato il 15 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 giu 1994 Consegnato il 15 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 10 gen 1992 Consegnato il 24 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise | |
Brevi particolari See form 395 ref M19C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 27 giu 1991 Consegnato il 03 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on all goodwill & uncalled capital. (See form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 08 mar 1989 Consegnato il 14 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 01 lug 1982 Consegnato il 20 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies deed or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23/2/78 | |
Brevi particolari Fixed charge on all book & other debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0