JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED

JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01331542
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1180 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLOTT & LOMAX (HOLDINGS) LIMITED27 set 197727 set 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Douglas il 17 dic 2020

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 28 ago 2020

    • Capitale: GBP 0.25
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/C. Cancel cap redemption reserve 07/08/2020
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Guy Douglas come amministratore in data 03 giu 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Seaton come amministratore in data 26 apr 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Seaton come amministratore in data 05 set 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Tejender Singh Chaudhary come segretario in data 23 mag 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Timothy Norris come segretario in data 23 mag 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Leon Anthony Power come amministratore in data 05 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Ross Shattock come amministratore in data 30 nov 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    246699210001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish259549880001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    Segretario
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    MITCHELL, William Gilchrist
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    Segretario
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    British6248520002
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    ROBERTS, John Maxwell, Dr
    Inglewood Mauldeth Road
    Heaton Mersey
    SK4 3NT Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Inglewood Mauldeth Road
    Heaton Mersey
    SK4 3NT Stockport
    Cheshire
    British13749500001
    UDOVIC, Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    162455140001
    BOISSIER, Roger Humphrey
    Easton House The Pastures
    Repton
    DE65 6GG Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Easton House The Pastures
    Repton
    DE65 6GG Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish19305640001
    BROADFOOT, William John Cameron
    43 Viewpark Drive, Burnside
    Rutherglen
    G73 3QE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    43 Viewpark Drive, Burnside
    Rutherglen
    G73 3QE Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish118078890001
    COMPSTON, David Gerald
    Parsons Hill
    Barbon
    LA6 2LS Kirkby Lonsdale
    Cumbria
    Amministratore
    Parsons Hill
    Barbon
    LA6 2LS Kirkby Lonsdale
    Cumbria
    British13749520001
    CUBITT, Mark
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    Amministratore
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    ScotlandBritish64309900002
    DEFFNER, Dieter, Dip-Ing
    Herweg 38b
    D-5060 Bergisch
    Gladbach 1
    Germany
    Amministratore
    Herweg 38b
    D-5060 Bergisch
    Gladbach 1
    Germany
    German28550160001
    DOWELL, John Rudkin
    40 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    40 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish21337810001
    FAWCETT, David Fred
    7 Mole House
    Court Mount Road
    GU27 2PR Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    7 Mole House
    Court Mount Road
    GU27 2PR Haslemere
    Surrey
    British31551220003
    HARDY, Peter Norman
    3 Elbury Croft
    Knowle
    B93 9QW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Elbury Croft
    Knowle
    B93 9QW Solihull
    West Midlands
    British21338060001
    HEATH, Robert Christopher
    232 Station Road
    CW7 3DF Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    232 Station Road
    CW7 3DF Winsford
    Cheshire
    British57400830001
    HILL, Edward John
    33 Netheravon Road
    Chiswick
    W4 2NA London
    Amministratore
    33 Netheravon Road
    Chiswick
    W4 2NA London
    British19688370003
    LEWITT, Frank Malcolm
    6 Warwick Road
    WA15 9NS Hale
    Cheshire
    Amministratore
    6 Warwick Road
    WA15 9NS Hale
    Cheshire
    British74473690003
    MILLS, John Herbert, Dr
    85 Ashworth Park
    WA16 9DG Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    85 Ashworth Park
    WA16 9DG Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish21475840001
    MITCHELL, William Gilchrist
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    Amministratore
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    British6248520002
    OGDEN, Andrew Thomas
    High Lea Barn
    High Lea Barn, Whins Lane
    BB12 7QU Simonstone
    Lancashire
    Amministratore
    High Lea Barn
    High Lea Barn, Whins Lane
    BB12 7QU Simonstone
    Lancashire
    British21338080005
    PASKINS, William James
    15 Danebank Road
    WA13 9DQ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    15 Danebank Road
    WA13 9DQ Lymm
    Cheshire
    British21338090001
    PERFECT, Henry George
    15 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4BS Glasgow
    Amministratore
    15 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4BS Glasgow
    ScotlandBritish493500002
    POWER, Leon Anthony
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    IrelandIrish126002790001
    ROBERTS, John Maxwell, Dr
    Inglewood Mauldeth Road
    Heaton Mersey
    SK4 3NT Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Inglewood Mauldeth Road
    Heaton Mersey
    SK4 3NT Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish13749500001
    SARGENT, Michael Henry Joseph
    5c Chapel Lane
    WA15 0HN Hale Barns
    Cheshire
    Amministratore
    5c Chapel Lane
    WA15 0HN Hale Barns
    Cheshire
    EnglandBritish111087920001
    SEATON, Paul
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    EnglandBritish204466160001
    SHORESON, Wilfred
    89 Silhill Hall Road
    B91 1JT Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    89 Silhill Hall Road
    B91 1JT Solihull
    West Midlands
    British21337800001
    SMITH, Alan Ormand
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    United KingdomBritish21338110002
    SMITH, Alan Ormand
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    17 Foxley Close
    WA13 0BS Lymm
    Cheshire
    United KingdomBritish21338110002
    WALLACE, William Angus
    6 Williamwood Park West
    Netherlee
    G44 3TE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    6 Williamwood Park West
    Netherlee
    G44 3TE Glasgow
    Lanarkshire
    British999680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Jacobs One Limited
    Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    95
    Scotland
    06 apr 2016
    Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    95
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneScottish Companies Registry
    Numero di registrazioneSc141100
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 gen 2000
    Consegnato il 18 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 dic 1991
    Consegnato il 19 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 giu 1988
    Consegnato il 01 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    14, fairlawns lauston close, merrow, guildford surrey, title no. 554801 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1983
    Consegnato il 07 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the fairbairn brindley telford house complex 21/25 ashton lane, sale, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 mar 1982
    Consegnato il 19 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land hereditaments and premises 8 floors of the main building of an office block known as the fairbairn brindley telford house complex, 21/25 ashton lane, sale, chester.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0