JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01331542 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1180 Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALLOTT & LOMAX (HOLDINGS) LIMITED | 27 set 1977 | 27 set 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Douglas il 17 dic 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 ago 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Guy Douglas come amministratore in data 03 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Seaton come amministratore in data 26 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Seaton come amministratore in data 05 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Tejender Singh Chaudhary come segretario in data 23 mag 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Timothy Norris come segretario in data 23 mag 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Leon Anthony Power come amministratore in data 05 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Ross Shattock come amministratore in data 30 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUDHARY, Tejender Singh | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | 246699210001 | |||||||
| DOUGLAS, Guy | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 258025190001 | |||||
| SHATTOCK, Jonathan R. | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | United Kingdom | British | 259549880001 | |||||
| MARKLEY, William Clyde | Segretario | 2105 Sunnybank Drive La Canada 91011 Flintridge California United States Of America | American | 57955380001 | ||||||
| MITCHELL, William Gilchrist | Segretario | 1 Henderland Drive Henderland Gate G61 1JJ Glasgow | British | 6248520002 | ||||||
| NORRIS, Michael Timothy | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | 52563600002 | ||||||
| ROBERTS, John Maxwell, Dr | Segretario | Inglewood Mauldeth Road Heaton Mersey SK4 3NT Stockport Cheshire | British | 13749500001 | ||||||
| UDOVIC, Michael | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | 162455140001 | |||||||
| BOISSIER, Roger Humphrey | Amministratore | Easton House The Pastures Repton DE65 6GG Derby Derbyshire | England | British | 19305640001 | |||||
| BROADFOOT, William John Cameron | Amministratore | 43 Viewpark Drive, Burnside Rutherglen G73 3QE Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 118078890001 | |||||
| COMPSTON, David Gerald | Amministratore | Parsons Hill Barbon LA6 2LS Kirkby Lonsdale Cumbria | British | 13749520001 | ||||||
| CUBITT, Mark | Amministratore | Duncraggan House 34 Airthrey Road FK9 5JS Stirling | Scotland | British | 64309900002 | |||||
| DEFFNER, Dieter, Dip-Ing | Amministratore | Herweg 38b D-5060 Bergisch Gladbach 1 Germany | German | 28550160001 | ||||||
| DOWELL, John Rudkin | Amministratore | 40 Amesbury Road Moseley B13 8LE Birmingham West Midlands | England | British | 21337810001 | |||||
| FAWCETT, David Fred | Amministratore | 7 Mole House Court Mount Road GU27 2PR Haslemere Surrey | British | 31551220003 | ||||||
| HARDY, Peter Norman | Amministratore | 3 Elbury Croft Knowle B93 9QW Solihull West Midlands | British | 21338060001 | ||||||
| HEATH, Robert Christopher | Amministratore | 232 Station Road CW7 3DF Winsford Cheshire | British | 57400830001 | ||||||
| HILL, Edward John | Amministratore | 33 Netheravon Road Chiswick W4 2NA London | British | 19688370003 | ||||||
| LEWITT, Frank Malcolm | Amministratore | 6 Warwick Road WA15 9NS Hale Cheshire | British | 74473690003 | ||||||
| MILLS, John Herbert, Dr | Amministratore | 85 Ashworth Park WA16 9DG Knutsford Cheshire | England | British | 21475840001 | |||||
| MITCHELL, William Gilchrist | Amministratore | 1 Henderland Drive Henderland Gate G61 1JJ Glasgow | British | 6248520002 | ||||||
| OGDEN, Andrew Thomas | Amministratore | High Lea Barn High Lea Barn, Whins Lane BB12 7QU Simonstone Lancashire | British | 21338080005 | ||||||
| PASKINS, William James | Amministratore | 15 Danebank Road WA13 9DQ Lymm Cheshire | British | 21338090001 | ||||||
| PERFECT, Henry George | Amministratore | 15 Thorn Road Bearsden G61 4BS Glasgow | Scotland | British | 493500002 | |||||
| POWER, Leon Anthony | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | Ireland | Irish | 126002790001 | |||||
| ROBERTS, John Maxwell, Dr | Amministratore | Inglewood Mauldeth Road Heaton Mersey SK4 3NT Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 13749500001 | |||||
| SARGENT, Michael Henry Joseph | Amministratore | 5c Chapel Lane WA15 0HN Hale Barns Cheshire | England | British | 111087920001 | |||||
| SEATON, Paul | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | England | British | 204466160001 | |||||
| SHORESON, Wilfred | Amministratore | 89 Silhill Hall Road B91 1JT Solihull West Midlands | British | 21337800001 | ||||||
| SMITH, Alan Ormand | Amministratore | 17 Foxley Close WA13 0BS Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 21338110002 | |||||
| SMITH, Alan Ormand | Amministratore | 17 Foxley Close WA13 0BS Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 21338110002 | |||||
| WALLACE, William Angus | Amministratore | 6 Williamwood Park West Netherlee G44 3TE Glasgow Lanarkshire | British | 999680001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs One Limited | 06 apr 2016 | Bothwell Street G2 7HX Glasgow 95 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 14 gen 2000 Consegnato il 18 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 02 dic 1991 Consegnato il 19 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 10 giu 1988 Consegnato il 01 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 14, fairlawns lauston close, merrow, guildford surrey, title no. 554801 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 gen 1983 Consegnato il 07 feb 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H the fairbairn brindley telford house complex 21/25 ashton lane, sale, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 08 mar 1982 Consegnato il 19 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land hereditaments and premises 8 floors of the main building of an office block known as the fairbairn brindley telford house complex, 21/25 ashton lane, sale, chester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0