CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED

CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01332718
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RIDSDALE DEVELOPMENTS LIMITED05 ott 197705 ott 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2012

    Stato del capitale al 19 ott 2012

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Sutherland il 24 ago 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Pamela June Smyth come segretario in data 16 mag 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Pamela June Smyth come amministratore in data 16 mag 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David Thomas Milloy il 28 set 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Euan James Edward Haggerty come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Donald Borland come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Hartley Miller il 08 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Pamela June Smyth il 08 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Pamela June Smyth il 08 nov 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Sutherland il 19 ott 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    5 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAGGERTY, Euan James Edward
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    ScotlandBritish162679260001
    MILLER, Philip Hartley
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    ScotlandBritish28512070005
    MILLOY, David Thomas
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    ScotlandBritish76474600001
    SUTHERLAND, Andrew
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    UkBritish66368290002
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    British41273760002
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Segretario
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    SMYTH, Pamela June
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Segretario
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    British65057960002
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Segretario
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    British43646700001
    BORLAND, Donald William
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    Amministratore
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    United KingdomBritish66010670002
    CUSSINS, Peter Ian
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish68297000001
    GREGORY, John Frederick
    185 Ballards Way
    CR0 5RJ Croydon
    Surrey
    Amministratore
    185 Ballards Way
    CR0 5RJ Croydon
    Surrey
    British1447590001
    HARRIS, Nicholas John
    Evenlode,248 Station Road
    B93 0ES Knowle
    West Midlands
    Amministratore
    Evenlode,248 Station Road
    B93 0ES Knowle
    West Midlands
    United KingdomBritish74890900001
    JACKSON, Julie Mansfield
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    Amministratore
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    United KingdomBritish94193070001
    SMYTH, Pamela June
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    C/O Miller
    2 Centro Place Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    ScotlandBritish65057960002
    WAITES, William Ian
    42 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    42 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish35575090001
    WOOD, Marlene
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish31152030002

    CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 29 set 1993
    Acquisito il 31 dic 1994
    Consegnato il 21 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    32 and 33 queen street,edinburgh and 32 north west thistle street land,edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 11 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 16 giu 1993
    Consegnato il 18 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being land on the west side of walworth road in the london borough of southwark t/n sgl 494953 with all buildings and fixtures by way of assignment the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 27 mar 1985
    Consegnato il 08 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus letter of set off
    Creato il 27 mar 1985
    Consegnato il 03 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sums or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mar 1981
    Consegnato il 16 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,000
    Brevi particolari
    L/H south of brunel street, newcastle-upon tyne ty 71102.
    Persone aventi diritto
    • Rothschild Trust Company Limited.
    • P. I. Cussins.
    Transazioni
    • 16 mar 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0