CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01332718 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RIDSDALE DEVELOPMENTS LIMITED | 05 ott 1977 | 05 ott 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Sutherland il 24 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Pamela June Smyth come segretario in data 16 mag 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Pamela June Smyth come amministratore in data 16 mag 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Thomas Milloy il 28 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Euan James Edward Haggerty come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Donald Borland come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Hartley Miller il 08 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Pamela June Smyth il 08 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Pamela June Smyth il 08 nov 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Sutherland il 19 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGGERTY, Euan James Edward | Amministratore | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Amministratore | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| MILLOY, David Thomas | Amministratore | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Amministratore | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | Uk | British | 66368290002 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Segretario | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Segretario | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Segretario | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | British | 65057960002 | ||||||
| WINDLE, Michael Patrick | Segretario | High Priar Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth Northumberland | British | 43646700001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Amministratore | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| CUSSINS, Peter Ian | Amministratore | Bitchfield Tower Belsay NE20 0JP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 68297000001 | |||||
| GREGORY, John Frederick | Amministratore | 185 Ballards Way CR0 5RJ Croydon Surrey | British | 1447590001 | ||||||
| HARRIS, Nicholas John | Amministratore | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | 74890900001 | |||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Amministratore | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| SMYTH, Pamela June | Amministratore | C/O Miller 2 Centro Place Pride Park DE24 8RF Derby Derbyshire | Scotland | British | 65057960002 | |||||
| WAITES, William Ian | Amministratore | 42 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | England | British | 35575090001 | |||||
| WOOD, Marlene | Amministratore | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
CUSSINS INVESTMENT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 29 set 1993 Acquisito il 31 dic 1994 Consegnato il 21 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 32 and 33 queen street,edinburgh and 32 north west thistle street land,edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 16 giu 1993 Consegnato il 18 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 set 1989 Consegnato il 02 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a or being land on the west side of walworth road in the london borough of southwark t/n sgl 494953 with all buildings and fixtures by way of assignment the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 27 mar 1985 Consegnato il 08 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus letter of set off | Creato il 27 mar 1985 Consegnato il 03 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari Any sums or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 05 mar 1981 Consegnato il 16 mar 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £45,000 | |
Brevi particolari L/H south of brunel street, newcastle-upon tyne ty 71102. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0