MENAMAY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMENAMAY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01338601
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MENAMAY LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova MENAMAY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Flat 7 Leeds Road
    Pannal
    HG3 1EP Harrogate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MENAMAY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MENAMAY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 64 st. Georges Road Harrogate North Yorkshire HG2 9DY England

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 64 st. Georges Road Harrogate North Yorkshire HG2 9DY in data 05 nov 2012

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Prospect Court Courthouse Street Otley West Yorkshire LS21 1AQ England

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Prospect Court 2 Courthouse Street, Otley, Nr. Leeds, West Yorkshire, LS21 1AQ, England in data 26 ott 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di John Ellison Lund come amministratore in data 26 ott 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Terri Louise Lund come segretario in data 26 ott 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Anthony Smith come amministratore in data 26 ott 2012

    2 pagineAP01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2011

    6 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2012

    Stato del capitale al 05 gen 2012

    • Capitale: GBP 12
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2009

    5 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MENAMAY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Anthony
    Leeds Road
    Pannal
    HG3 1EP Harrogate
    Flat 7
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    Pannal
    HG3 1EP Harrogate
    Flat 7
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish173198130002
    HARGREAVES, David Edward
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British5518690001
    HARGREAVES, Evelyn
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British5824160001
    LUND, Terri Louise
    Brooklands, Chevin Avenue
    Bradford Road, Menston
    LS29 6DY Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Brooklands, Chevin Avenue
    Bradford Road, Menston
    LS29 6DY Ilkley
    West Yorkshire
    British13305770001
    HARGREAVES, David Edward
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British5518690001
    HARGREAVES, Evelyn
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British5824160001
    HARGREAVES, Jessica
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British52731480001
    HARGREAVES, Joanne
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 St Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British49904030001
    HARGREAVES, Michelle
    79 Saint Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 Saint Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British92968580001
    HARGREAVES, Michelle
    79 Saint Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    79 Saint Richards Road
    LS21 2AL Otley
    West Yorkshire
    British92968580001
    LUND, John Ellison
    Brooklands Chevin Avenue
    Menston
    LS29 6DY Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brooklands Chevin Avenue
    Menston
    LS29 6DY Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish43934690001

    MENAMAY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 06 lug 2010
    Consegnato il 10 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 1-5 oldfield lane wortley leeds t/n's WYK508250, WYK171752, WYK250533 and WYK122268 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 10 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 2008
    Consegnato il 05 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1-5 oldfield lane, wortley, leeds t/no WYK508520, WYK171752, WYK250533 and WYK122268.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1-5 oldfield lane wortley leeds t/no's WYK508520/WYK171752/WYK250533 and WYK122268.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 ago 1992
    Consegnato il 15 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plus patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mar 1992
    Consegnato il 04 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises k/a the warehouse premises situate in oldfield lane, wortley, leeds together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of consent
    Creato il 01 ago 1978
    Consegnato il 16 ago 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All beneficial interest in f/h property as copley hill, wortley, leeds title no:- wyk 122268.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank LTD
    Transazioni
    • 16 ago 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 15 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0