CAPITAL VALVES LIMITED

CAPITAL VALVES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPITAL VALVES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01339812
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPITAL VALVES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CAPITAL VALVES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Units 15 & 16 Blackfriars Court Excalibur Road
    Beacon Park
    NR31 7RQ Gorleston
    Great Yarmouth
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPITAL VALVES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARNLEY VALVES LIMITED18 ago 198218 ago 1982
    ARNLEY CAPITAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    CALIFORNIA FREE FORMER (U.K.) LIMITED21 nov 197721 nov 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPITAL VALVES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPITAL VALVES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Steven Mclean come amministratore in data 07 feb 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 8B St Leger Drive Newmarket Suffolk CB8 7DT United Kingdom a Units 15 & 16 Blackfriars Court Excalibur Road Beacon Park Gorleston Great Yarmouth NR31 7RQ in data 02 dic 2019

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Capital Valves Holdings Limited come persona con controllo significativo il 02 dic 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Alan Freeland come segretario in data 25 mag 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ethel Victoria Speirs come segretario in data 25 mag 2018

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Ethel Victoria Speirs il 20 mar 2018

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Mclean il 20 mar 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Freeland il 20 mar 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Gary Michael Williams come amministratore in data 02 feb 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Steven Mclean come amministratore in data 12 dic 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Alan Freeland come amministratore in data 12 dic 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Michael Williams il 06 set 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di David Wyness Napier come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CAPITAL VALVES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FREELAND, Alan
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    Segretario
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    247128390001
    FREELAND, Alan
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    Amministratore
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director196008270001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163574640001
    GIBBON, Susan
    Owls Lodge 139 Chatsworth Road
    NW2 5QT London
    Segretario
    Owls Lodge 139 Chatsworth Road
    NW2 5QT London
    British1832340001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    Segretario
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    British158261540001
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    SPEIRS, Ethel Victoria
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    Segretario
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    189601730001
    WALKER, Anita Sheila
    1 Norfolk Road
    NW8 6AX London
    Segretario
    1 Norfolk Road
    NW8 6AX London
    BritishHousewife8465040001
    WISE OWL SECRETAIRES LTD
    18a Pindock Mews
    Little Venice
    W9 2PY London
    Segretario
    18a Pindock Mews
    Little Venice
    W9 2PY London
    72709230002
    BOYLE, Thomas Douglas
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    UkBritishCompany Director61611910001
    CHANDLER, Graham William
    8 Bury Mead
    SG15 6UB Arlesey
    Bedfordshire
    Amministratore
    8 Bury Mead
    SG15 6UB Arlesey
    Bedfordshire
    EnglandBritishEngineer70193540003
    COWIE, Iain
    15th Floor
    Wembley Point
    HA9 6DE Wembley
    Middlesex
    Amministratore
    15th Floor
    Wembley Point
    HA9 6DE Wembley
    Middlesex
    United KingdomBritishSales99959310002
    CUSH, Thomas
    2057 Hampton Way
    Merrick
    FOREIGN New York
    New York Ny 11586
    Usa
    Amministratore
    2057 Hampton Way
    Merrick
    FOREIGN New York
    New York Ny 11586
    Usa
    Us CitizenCompany President13521370001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Amministratore
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritishUk Country Controller180854890001
    GIBBON, Susan
    Owls Lodge 139 Chatsworth Road
    NW2 5QT London
    Amministratore
    Owls Lodge 139 Chatsworth Road
    NW2 5QT London
    EnglandBritishCompany Director1832340001
    HAVERTY, Michael Thomas
    Badentoy Avenue, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YB Aberdeen
    Distributionnow
    Scotland
    Amministratore
    Badentoy Avenue, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YB Aberdeen
    Distributionnow
    Scotland
    ScotlandBritishCountry Manager188460720001
    HOLDER, Ashley Madelaine Gail
    4
    St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    4
    St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director24983280004
    KEENER, David James
    Oranjestraat 33
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Netherlands
    Amministratore
    Oranjestraat 33
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Netherlands
    NetherlandsUsaCompany Director161469350001
    LEAHY, Terence Paul
    2 Queens Road
    W5 2SA London
    Amministratore
    2 Queens Road
    W5 2SA London
    United KingdomBritishCompany Director6766950002
    MAHAN, Ryan Thomas
    Badentoy Avenue, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YB Aberdeen
    Distributionnow
    Scotland
    Amministratore
    Badentoy Avenue, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YB Aberdeen
    Distributionnow
    Scotland
    ScotlandUsaArea Director188461420001
    MCLEAN, Steven
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    Amministratore
    Altens
    AB12 3HT Aberdeen
    Peterseat Drive
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director241180230001
    NAPIER, David Wyness
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8XA Aberdeen
    79
    Scotland
    Amministratore
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8XA Aberdeen
    79
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Controller147413520001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishVp Finance Europe162062160001
    VALENTINE, Steven Grenville
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director92773870002
    WALKER, Jeffrey Maxwell
    1 Norfolk Road
    NW8 6AX London
    Amministratore
    1 Norfolk Road
    NW8 6AX London
    United KingdomBritishChartered Accountant6766960001
    WILLIAMS, Gary Michael
    1948 Rc
    Beverwijk
    Gooiland 12
    Netherlands
    Amministratore
    1948 Rc
    Beverwijk
    Gooiland 12
    Netherlands
    NetherlandsAmericanSales And Operations Director196682620007

    Chi sono le persone con controllo significativo di CAPITAL VALVES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Excalibur Road
    Beacon Park
    NR31 7RQ Gorleston
    Units 15 & 16 Blackfriars Court
    Great Yarmouth
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Excalibur Road
    Beacon Park
    NR31 7RQ Gorleston
    Units 15 & 16 Blackfriars Court
    Great Yarmouth
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07193512
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CAPITAL VALVES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 12 set 2010
    Consegnato il 17 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All amounts now and in the future credited to a/no 140/01/26073021.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 15 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2, part 15TH floor, wembley point, 1 harrow road, wembley, middlesex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 ott 1997
    Consegnato il 16 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0