LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED

LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINK HOUSE MAGAZINES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01341560
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor 60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LINK HOUSE MAGAZINES (CROYDON) LIMITED01 dic 197701 dic 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR in data 20 ago 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Lh Media Limited come persona con controllo significativo il 20 ago 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 13 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 13 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marcus Alvin Rich come amministratore in data 13 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Susana D'emic come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Stanley Zieser come amministratore in data 15 feb 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Joseph Henry Ceryanec come amministratore in data 15 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lauren Ezrol Klein come segretario in data 31 gen 2018

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Susana D'emic come amministratore in data 07 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeffrey John Bairstow come amministratore in data 07 nov 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Charles Lloyd Meredith come amministratore in data 31 mag 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 giu 2016

    Stato del capitale al 07 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CERYANEC, Joseph Henry
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    United StatesAmerican243478830001
    ZIESER, John Stanley
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    United StatesAmerican243480710001
    DAVIES, John Graeme
    The Coach House Ghyll Head
    Waterhead
    LA22 0HD Ambleside
    Cumbria
    Segretario
    The Coach House Ghyll Head
    Waterhead
    LA22 0HD Ambleside
    Cumbria
    British72253030001
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Segretario
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Segretario
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    PEDEN, Michael Timothy
    West Gate 38 Worgret Road
    BH20 4PN Wareham
    Dorset
    Segretario
    West Gate 38 Worgret Road
    BH20 4PN Wareham
    Dorset
    British46871090001
    PYPER, Richard John
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    Segretario
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    British74495760001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Segretario
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Segretario
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Amministratore
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Amministratore
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Amministratore
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Amministratore
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    BROWNING, David John Walter
    2 Roman Walk
    BR2 8QN Bromley
    Kent
    Amministratore
    2 Roman Walk
    BR2 8QN Bromley
    Kent
    British22103090001
    CAMERON, Andrew
    6 Sandy Lodge Road
    WD3 1LJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Sandy Lodge Road
    WD3 1LJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    HertfordshireBritish109533650001
    COSGROVE, Peter John
    21 Kelsey Way
    BR3 3LP Beckenham
    Kent
    Amministratore
    21 Kelsey Way
    BR3 3LP Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish580050001
    D'EMIC, Susana Alves
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DOWNING, Brian George Kirby
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    British8426380001
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Amministratore
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    GAMM, Colin Keith
    23 Northampton Road
    CR0 7HB Croydon
    Surrey
    Amministratore
    23 Northampton Road
    CR0 7HB Croydon
    Surrey
    British580060001
    HAMPEL, Paul Leonard
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    British57201570001
    HAMPEL, Paul Leonard
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    British57201570001
    JAKES, Clifford Duncan
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    British8426370001
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Amministratore
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritish99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Amministratore
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    MAY, Stephen John
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    United KingdomBritish173367920001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish189455000001
    MORGAN, Alan Ronald George
    11 Wavell Court Elgin Road
    CR0 6XB Croydon
    Amministratore
    11 Wavell Court Elgin Road
    CR0 6XB Croydon
    British46480460001
    PYPER, Richard John
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    British74495760001
    RICH, Marcus Alvin
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Amministratore
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03028809
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 02 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Link house 9 dingwall avenue croydon offices and 36 parking spaces; 23-25A george street croydon surrey studio offices workshops storage and 8 parking spaces; 583 fulham road london SW6 office and 2 parking spaces .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment amending a deed of accession between the chargor, ipc magazines (UK) limited and the security agent supplemental to the debenture dated 19TH january 1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future monies and liabilities of the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession supplemental to the debenture and the debenture
    Creato il 12 ott 1998
    Consegnato il 15 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 08 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0