LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01341560 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LINK HOUSE MAGAZINES (CROYDON) LIMITED | 01 dic 1977 | 01 dic 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR in data 20 ago 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Lh Media Limited come persona con controllo significativo il 20 ago 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 13 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 13 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Alvin Rich come amministratore in data 13 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Susana D'emic come amministratore in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Stanley Zieser come amministratore in data 15 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Joseph Henry Ceryanec come amministratore in data 15 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lauren Ezrol Klein come segretario in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Susana D'emic come amministratore in data 07 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey John Bairstow come amministratore in data 07 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Lloyd Meredith come amministratore in data 31 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Amministratore | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 243480710001 | |||||
| DAVIES, John Graeme | Segretario | The Coach House Ghyll Head Waterhead LA22 0HD Ambleside Cumbria | British | 72253030001 | ||||||
| GORE, John Francis | Segretario | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Segretario | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Segretario | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| PEDEN, Michael Timothy | Segretario | West Gate 38 Worgret Road BH20 4PN Wareham Dorset | British | 46871090001 | ||||||
| PYPER, Richard John | Segretario | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| REDPATH, John | Segretario | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Segretario | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ALEY, William Robert | Amministratore | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Amministratore | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Amministratore | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Amministratore | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Amministratore | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| BROWNING, David John Walter | Amministratore | 2 Roman Walk BR2 8QN Bromley Kent | British | 22103090001 | ||||||
| CAMERON, Andrew | Amministratore | 6 Sandy Lodge Road WD3 1LJ Rickmansworth Hertfordshire | Hertfordshire | British | 109533650001 | |||||
| COSGROVE, Peter John | Amministratore | 21 Kelsey Way BR3 3LP Beckenham Kent | United Kingdom | British | 580050001 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DOWNING, Brian George Kirby | Amministratore | 35 Badingham Drive Fetcham KT22 9EU Leatherhead Surrey | British | 8426380001 | ||||||
| EVANS, Richard John | Amministratore | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Amministratore | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| GAMM, Colin Keith | Amministratore | 23 Northampton Road CR0 7HB Croydon Surrey | British | 580060001 | ||||||
| HAMPEL, Paul Leonard | Amministratore | 13 Pottery Lane CM1 4HH Chelmsford Essex | British | 57201570001 | ||||||
| HAMPEL, Paul Leonard | Amministratore | 13 Pottery Lane CM1 4HH Chelmsford Essex | British | 57201570001 | ||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Amministratore | Littlehay Burley BH24 4AG Ringwood Hampshire | British | 8426370001 | ||||||
| MAIR, Denise Margaret | Amministratore | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Amministratore | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MORGAN, Alan Ronald George | Amministratore | 11 Wavell Court Elgin Road CR0 6XB Croydon | British | 46480460001 | ||||||
| PYPER, Richard John | Amministratore | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Amministratore | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lh Media Limited | 06 apr 2016 | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 02 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Link house 9 dingwall avenue croydon offices and 36 parking spaces; 23-25A george street croydon surrey studio offices workshops storage and 8 parking spaces; 583 fulham road london SW6 office and 2 parking spaces .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment amending a deed of accession between the chargor, ipc magazines (UK) limited and the security agent supplemental to the debenture dated 19TH january 1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998 | Creato il 22 dic 1998 Consegnato il 06 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future monies and liabilities of the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession supplemental to the debenture and the debenture | Creato il 12 ott 1998 Consegnato il 15 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mar 1995 Consegnato il 08 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0