HAMSTAR PROPERTIES LIMITED

HAMSTAR PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAMSTAR PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01342234
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Brooklands Place
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    Cheshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Hamstar Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 21 dic 2017

    2 paginePSC05

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Laura Grace Montgomery il 18 dic 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Laura Grace Montgomery il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Harold Sharp Chartered Accountants Holland House 1-5 Oakfield Sale Cheshire M33 6TT England a C/O Harold Sharp Chartered Accountants 5 Brooklands Place Brooklands Road Sale Cheshire M33 3SD

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Holland House 1-5 Oakfield Sale Cheshire M33 6TT a 5 Brooklands Place Brooklands Road Sale Cheshire M33 3SD in data 19 dic 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Holland House 1-5 Oakfield Sale Cheshire M33 6TT

    1 pagineAD04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Harold Sharp Chartered Accountants Holland House 1-5 Oakfield Sale Cheshire M33 6TT

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Harold Sharp Chartered Accountants Holland House 1-5 Oakfield Sale Cheshire M33 6TT

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2015

    Stato del capitale al 30 lug 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Laura Grace Montgomery il 20 lug 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per John Austen Anstruther Gough Calthorpe il 20 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Laura Grace Montgomery il 20 lug 2014

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MONTGOMERY, Laura Grace
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    Segretario
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    British75785850004
    CALTHORPE, John Austen Anstruther Gough
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish98057750003
    MONTGOMERY, Laura Grace
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Brooklands Road
    M33 3SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    EnglandBritish75785850006
    CAMPBELL, Linda Frances
    Shalden Park House
    Shalden
    GU34 4DS Alton
    Hampshire
    Segretario
    Shalden Park House
    Shalden
    GU34 4DS Alton
    Hampshire
    British13439230001
    EVETTS, Andrea Sari Victoria
    53 Green Lane
    GU9 8QE Farnham
    Surrey
    Segretario
    53 Green Lane
    GU9 8QE Farnham
    Surrey
    British10274390001
    ALDRIDGE, Trevor Martin
    Offley
    SG5 3DB Hitchin
    Birkitt Hill House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Offley
    SG5 3DB Hitchin
    Birkitt Hill House
    Hertfordshire
    British42736850001
    BACKHOUSE, David Miles
    South Farm House
    Hatherop
    GL7 3PN Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    South Farm House
    Hatherop
    GL7 3PN Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish407140001
    CAMPBELL, Doris
    Cotterell House Hound House Road
    Shere
    GU5 9JG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Cotterell House Hound House Road
    Shere
    GU5 9JG Guildford
    Surrey
    British13406300001
    CAMPBELL, Linda Frances
    Shalden Park House
    Shalden
    GU34 4DS Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Shalden Park House
    Shalden
    GU34 4DS Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish13439230001
    CUNNINGHAM, Heather Ruth
    Bluebell Farm Manchester Road
    WA16 0SR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Bluebell Farm Manchester Road
    WA16 0SR Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish40484230001
    DONALD, Graeme Gardner
    Pine Ridge West Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JS Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Pine Ridge West Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JS Farnham
    Surrey
    British13406290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAMSTAR PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hamstar Holdings Ltd
    Brooklands Road
    M33 2SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    06 apr 2016
    Brooklands Road
    M33 2SD Sale
    5 Brooklands Place
    Cheshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimted Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Register Of Companies
    Numero di registrazione06696408
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HAMSTAR PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Memorandum of deposit of deeds
    Creato il 31 dic 1992
    Consegnato il 07 gen 1993
    In corso
    Importo garantito
    £220000
    Brevi particolari
    The properties listed on form 395 ref 292.
    Persone aventi diritto
    • Ellis Campbell
    Transazioni
    • 07 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1988
    Consegnato il 13 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The malthouse barn rapley hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 set 1987
    Consegnato il 09 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that fixed property at 46 downing street farnham surrey t/no sy 376543 together with all fixtures whatsoever (other than trade machinery).
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar & Company PLC
    Transazioni
    • 09 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 feb 1985
    Consegnato il 11 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The following f/h properties all on the birstall estate in leicester namely 22 belgrave boulevard, 8 & 54 helena crescent, 282 thurcaston road, 51 & 61 woodstock rd, 33 ashill drive t/no:- lt 60636. together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar and Company Limited.
    Transazioni
    • 11 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1982
    Consegnato il 07 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property known as 28 draycott place, SW3. Kensington and chelsea title no. 167151 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar & Company Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 ott 1981
    Consegnato il 28 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 67 stanley road and 107 potter street london borough of harrow title no. Ngl 350094 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to th eproperty or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar and Company Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0