CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01346606
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    • Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative
    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    NEVRUS TWO LIMITED03 gen 197803 gen 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG in data 21 ott 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 ott 2021

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Rankin Cummings il 19 mar 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Richard Bradbrook come amministratore in data 18 mag 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Rankin Cummings come amministratore in data 18 mag 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul Andrew Jardine come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Ashwell come amministratore in data 26 set 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Clynton Jacobus Luttig come amministratore in data 26 set 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2016

    Stato del capitale al 04 mar 2016

    • Capitale: GBP 999,900
    SH01

    Cessazione della carica di Robert Callan come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201004180001
    ASHWELL, Stephen Michael
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish192559400001
    CUMMINGS, Mark Rankin
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish254912020002
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    BUSHER, Thomas George Story
    4a Drayton Court
    Drayton Gardens
    SW10 9RQ London
    Segretario
    4a Drayton Court
    Drayton Gardens
    SW10 9RQ London
    British6386010001
    DAVIES, Sarah Ann
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    British66138540001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Segretario
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Segretario
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    British100201680002
    NOONE, Lisa Marie
    7 Woodstone Avenue
    IP1 3TE Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    7 Woodstone Avenue
    IP1 3TE Ipswich
    Suffolk
    British72182310001
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Segretario
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Segretario
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    TIMMINS, Eleanor Bharti Yvonne
    Flat 2 8 Eversfield Road
    Kew
    TW9 2AP Richmond
    Surrey
    Segretario
    Flat 2 8 Eversfield Road
    Kew
    TW9 2AP Richmond
    Surrey
    British42173620001
    AGNEW, Ian Charles
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    Amministratore
    23 Chalfont House
    19 Chesham Street
    SW1X 8NG London
    British6418620003
    ALEXANDER, John Lindsay, Sir
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    British6418630001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Amministratore
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BARTON, Robert John Orr
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    Amministratore
    33 Rutland Court
    Rutland Gardens
    SW7 1BW London
    British7999080003
    BENHAM, Stephen
    Smythe Cottage
    Wenlock Lane
    CM4 0JG Blackmore
    Essex
    Amministratore
    Smythe Cottage
    Wenlock Lane
    CM4 0JG Blackmore
    Essex
    British38793500002
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURROWS, Timothy William
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    37 Northumberland Road
    New Barnet
    EN5 1EB Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish126815810002
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    CAPRON, Adam David
    Coach House
    The Green, Leckhampstead
    RG20 8QH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Coach House
    The Green, Leckhampstead
    RG20 8QH Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish122237920001
    CHAPMAN, Neil Richard
    30 South Street
    SS4 1BQ Rochford
    Essex
    Amministratore
    30 South Street
    SS4 1BQ Rochford
    Essex
    British73334580001
    COLEMAN, Barry
    Batchelors
    Barns Green
    RH13 7QG Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Batchelors
    Barns Green
    RH13 7QG Horsham
    West Sussex
    British15199730001
    COOPER, Anthony Geoffrey
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    British73654090001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DAVIES, Sarah Ann
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Holly Bush Lane
    Bendish
    SG4 8JB Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish66138540001
    DE HALDEVANG, Bernard Goetz Michael Imka
    44a Lavender Sweep
    SW11 1HD London
    Amministratore
    44a Lavender Sweep
    SW11 1HD London
    British73476700001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Amministratore
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    ENGESTROM, John
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Yardley Farm
    Chequers Lane
    LU7 9AG Pitstone
    Buckinghamshire
    Swedish67286160004
    EWBANK, Ronald Joseph
    23 Dean Close
    Pyrford
    GU22 8NX Woking
    Surrey
    Amministratore
    23 Dean Close
    Pyrford
    GU22 8NX Woking
    Surrey
    British71972950001
    FOREMAN, David Peter
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    Amministratore
    Ringers Farm
    Russ Hill Road Charlwood
    RH6 0EW Horley
    Surrey
    EnglandBritish121083690001
    FRANKS, Howard Alistair Lionel
    96 Woodstock Road
    Chiswick
    W4 1EG London
    Amministratore
    96 Woodstock Road
    Chiswick
    W4 1EG London
    British24301440002
    FREEMAN, Philip John
    114 Farmers Way
    SL6 3PU Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    114 Farmers Way
    SL6 3PU Maidenhead
    Berkshire
    British24301450001
    FRESHWATER, Neil Andrew, Mr.
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1949119
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over experience account
    Creato il 07 gen 2005
    Consegnato il 27 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the members of the lloyd's syndicates to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the deposit, the experience account, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit and the experience account and by way of floating charge all entitlements to interest on the deposit being £18,346,448.67. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First National Litigation Funding PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 dic 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 27 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 lug 1997
    Consegnato il 29 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 nov 1992
    Consegnato il 21 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 dic 1985
    Consegnato il 13 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 30 dic 1985
    Consegnato il 06 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from wellington underwriting limited to the chargee under terms of the charge
    Brevi particolari
    Borrowers interest in the l/h properties etc and/or the proceeds of sale thereof specific charge over all other securities etc the goodwill & uncalled capital etc. floating charge undertaking and all property and assets present and future (see doc M34 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co. Limited
    Transazioni
    • 06 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    CATLIN (WELLINGTON) UNDERWRITING AGENCIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ott 2021Inizio della liquidazione
    22 ott 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0