REDHEAD FREIGHT LIMITED

REDHEAD FREIGHT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDHEAD FREIGHT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01355753
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    • Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio
    • Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Nomina di Mr John Mark Gillam come amministratore in data 03 lug 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Aaron Scott come amministratore in data 03 lug 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 mar 2023

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE England a Units 1-3 Hilltop Business Park Devizes Road Salisbury Wiltshire SP3 4UF in data 08 apr 2023

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Declan Joseph Byrne come amministratore in data 20 mar 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    That the memorandum of association of the company be and is hereby removed with immediate effect 21/10/2022
    RES13

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio redatto al 30 giu 2021

    37 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Ms Nichola Claire Watts come segretario in data 31 mag 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Keith Michael Shackleton come segretario in data 31 mag 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    35 pagineAA

    Nomina di Mr Declan Joseph Byrne come amministratore in data 01 giu 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Aaron Scott come amministratore in data 01 giu 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Spencer Cosgrove come amministratore in data 01 giu 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Anthony Suggitt come amministratore in data 01 giu 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate Dealburn Road, Low Moor Bradford BD12 0RG a Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE in data 28 mag 2021

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Philip Andrew Baxter come amministratore in data 26 gen 2021

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATTS, Nichola Claire
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Segretario
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    297395770001
    GILLAM, John Mark
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Amministratore
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    EnglandBritish117224540004
    DERRY, Michael John
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Segretario
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    British21636860002
    SHACKLETON, Keith Michael
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Segretario
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    159083830001
    ADAMSON, Gerard Nicholas Paul
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandEnglish74467030001
    ADAMSON, Gerard Nicholas Paul
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandEnglish74467030001
    BAXTER, Philip Andrew
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    United KingdomEnglish89307610002
    BYRNE, Declan Joseph
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Amministratore
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    IrelandIrish283914830001
    COCKROFT, Robert Michael
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    United KingdomBritish168058660002
    COSGROVE, Mark Spencer
    Mallusk Drive
    BT36 4GX Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    Mallusk Drive
    BT36 4GX Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish140466750004
    DERRY, Michael John
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandBritish21636860002
    HEIKEN, Reiner
    Edmund-Rumpler-Str. 3
    60549 Frankfurt
    Schenker Europe Gmbh
    Germany
    Amministratore
    Edmund-Rumpler-Str. 3
    60549 Frankfurt
    Schenker Europe Gmbh
    Germany
    GermanyGerman244535340001
    JOHNSTON, David
    2 Cooper Close
    Lady Lane
    BD16 4SD Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Cooper Close
    Lady Lane
    BD16 4SD Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish58080390001
    KAISER, Ewald
    Colmore Row
    B3 2AB Birmingham
    Mills & Reeve Llp, 78-84
    United Kingdom
    Amministratore
    Colmore Row
    B3 2AB Birmingham
    Mills & Reeve Llp, 78-84
    United Kingdom
    GermanyGerman205093650001
    LUXTON, Richard Herbert
    33 Bromley Road
    Nab Wood
    BD18 4DT Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Bromley Road
    Nab Wood
    BD18 4DT Shipley
    West Yorkshire
    British57400420001
    REDHEAD, Jack
    Manor Barn Horners Fold
    Greeen End Road East Morton
    BD20 5TU Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Manor Barn Horners Fold
    Greeen End Road East Morton
    BD20 5TU Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish80279510001
    RUSSAM, Reginald Charles Lancaster
    The Bungalow
    Leeds Old Road
    BD3 7EW Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Bungalow
    Leeds Old Road
    BD3 7EW Bradford
    West Yorkshire
    British21636910001
    SCOTT, Aaron
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Amministratore
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    EnglandEnglish321518690001
    SUGGITT, Paul Anthony
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Amministratore
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    EnglandBritish21636880004
    THACKER, Robert Ian
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Amministratore
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandBritish21636900002

    Chi sono le persone con controllo significativo di REDHEAD FREIGHT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    30 ott 2020
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    No
    Forma giuridicaLtd
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00383914
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Schenker Aktiengesellschaft
    Kruppstrasse
    Essen
    4
    45128
    Germany
    06 apr 2016
    Kruppstrasse
    Essen
    4
    45128
    Germany
    Forma giuridicaJoint Stock Corporation
    Paese di registrazioneGermany
    Autorità legaleGerman
    Luogo di registrazioneEssen Commercial Register
    Numero di registrazioneHrb 17474
    Cerca nel registro delle imprese tedescoSchenker Aktiengesellschaft
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    REDHEAD FREIGHT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 15 ott 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 13 northwest business park ballycoolin dublin 15.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Solicitors undertaking executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Creato il 27 giu 2005
    Consegnato il 14 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 13, northwest business park, ballycoolin, dublin 15.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transazioni
    • 14 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 nov 2002
    Consegnato il 07 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of spartan road low moor bradford west yorkshire t/n WYK193547. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of dealburn road low moor bradford t/n WYK570920. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2020Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 28 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 set 1997
    Consegnato il 18 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1995
    Consegnato il 22 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land containing approx. 4.75 acres at dealburn road low moor bradford west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 22 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1995
    Consegnato il 21 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at dealburn road low moor bradford comprising approximately 4.75 acres, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,177.81 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M191C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Prompt credit application
    Creato il 11 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,940.30
    Brevi particolari
    All right title & interest in & to all sums payable....under the insurance (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers LTD
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1987
    Consegnato il 13 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south west side of dealburn road, law moor, bradford, west yorkshire title no - wyk 288973.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1986
    Consegnato il 19 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 mar 1982
    Consegnato il 07 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1982Registrazione di un'ipoteca

    REDHEAD FREIGHT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mar 2023Inizio della liquidazione
    27 giu 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Powell
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Praticante
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Julie Anne Palmer
    Begbies Traynor (Central) Llp Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0