REDHEAD FREIGHT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REDHEAD FREIGHT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01355753 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REDHEAD FREIGHT LIMITED?
- Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio
- Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova REDHEAD FREIGHT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Units 1-3 Hilltop Business Park Devizes Road SP3 4UF Salisbury Wiltshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di REDHEAD FREIGHT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per REDHEAD FREIGHT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di Mr John Mark Gillam come amministratore in data 03 lug 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Aaron Scott come amministratore in data 03 lug 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE England a Units 1-3 Hilltop Business Park Devizes Road Salisbury Wiltshire SP3 4UF in data 08 apr 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Declan Joseph Byrne come amministratore in data 20 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2021 | 37 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Nomina di Ms Nichola Claire Watts come segretario in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Michael Shackleton come segretario in data 31 mag 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 35 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Declan Joseph Byrne come amministratore in data 01 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Aaron Scott come amministratore in data 01 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Spencer Cosgrove come amministratore in data 01 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Anthony Suggitt come amministratore in data 01 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate Dealburn Road, Low Moor Bradford BD12 0RG a Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE in data 28 mag 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Andrew Baxter come amministratore in data 26 gen 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REDHEAD FREIGHT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATTS, Nichola Claire | Segretario | Hilltop Business Park Devizes Road SP3 4UF Salisbury Units 1-3 Wiltshire | 297395770001 | |||||||
| GILLAM, John Mark | Amministratore | Hilltop Business Park Devizes Road SP3 4UF Salisbury Units 1-3 Wiltshire | England | British | 117224540004 | |||||
| DERRY, Michael John | Segretario | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | British | 21636860002 | ||||||
| SHACKLETON, Keith Michael | Segretario | Scylla Road London Heathrow Airport TW6 3FE Hounslow Schenker House England | 159083830001 | |||||||
| ADAMSON, Gerard Nicholas Paul | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | England | English | 74467030001 | |||||
| ADAMSON, Gerard Nicholas Paul | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | England | English | 74467030001 | |||||
| BAXTER, Philip Andrew | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | United Kingdom | English | 89307610002 | |||||
| BYRNE, Declan Joseph | Amministratore | Scylla Road London Heathrow Airport TW6 3FE Hounslow Schenker House England | Ireland | Irish | 283914830001 | |||||
| COCKROFT, Robert Michael | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | United Kingdom | British | 168058660002 | |||||
| COSGROVE, Mark Spencer | Amministratore | Mallusk Drive BT36 4GX Newtownabbey 5 County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 140466750004 | |||||
| DERRY, Michael John | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | England | British | 21636860002 | |||||
| HEIKEN, Reiner | Amministratore | Edmund-Rumpler-Str. 3 60549 Frankfurt Schenker Europe Gmbh Germany | Germany | German | 244535340001 | |||||
| JOHNSTON, David | Amministratore | 2 Cooper Close Lady Lane BD16 4SD Bingley West Yorkshire | England | British | 58080390001 | |||||
| KAISER, Ewald | Amministratore | Colmore Row B3 2AB Birmingham Mills & Reeve Llp, 78-84 United Kingdom | Germany | German | 205093650001 | |||||
| LUXTON, Richard Herbert | Amministratore | 33 Bromley Road Nab Wood BD18 4DT Shipley West Yorkshire | British | 57400420001 | ||||||
| REDHEAD, Jack | Amministratore | Manor Barn Horners Fold Greeen End Road East Morton BD20 5TU Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | 80279510001 | |||||
| RUSSAM, Reginald Charles Lancaster | Amministratore | The Bungalow Leeds Old Road BD3 7EW Bradford West Yorkshire | British | 21636910001 | ||||||
| SCOTT, Aaron | Amministratore | Hilltop Business Park Devizes Road SP3 4UF Salisbury Units 1-3 Wiltshire | England | English | 321518690001 | |||||
| SUGGITT, Paul Anthony | Amministratore | Scylla Road London Heathrow Airport TW6 3FE Hounslow Schenker House England | England | British | 21636880004 | |||||
| THACKER, Robert Ian | Amministratore | Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor Bradford | England | British | 21636900002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REDHEAD FREIGHT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schenker Limited | 30 ott 2020 | Scylla Road London Heathrow Airport TW6 3FE Hounslow Schenker House England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
| Schenker Aktiengesellschaft | 06 apr 2016 | Kruppstrasse Essen 4 45128 Germany | Sì | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
REDHEAD FREIGHT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 15 ott 2005 Consegnato il 03 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Unit 13 northwest business park ballycoolin dublin 15. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Solicitors undertaking executed outside the united kingdom and comprising property situated there | Creato il 27 giu 2005 Consegnato il 14 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Unit 13, northwest business park, ballycoolin, dublin 15. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 01 nov 2002 Consegnato il 07 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the east side of spartan road low moor bradford west yorkshire t/n WYK193547. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 01 feb 2001 Consegnato il 09 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a land and buildings on the south side of dealburn road low moor bradford t/n WYK570920. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 feb 2001 Consegnato il 09 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 05 set 1997 Consegnato il 18 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 apr 1995 Consegnato il 22 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H land containing approx. 4.75 acres at dealburn road low moor bradford west yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 apr 1995 Consegnato il 21 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at dealburn road low moor bradford comprising approximately 4.75 acres, west yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 07 apr 1993 Consegnato il 15 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £17,177.81 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M191C for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Prompt credit application | Creato il 11 mag 1992 Consegnato il 27 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,940.30 | |
Brevi particolari All right title & interest in & to all sums payable....under the insurance (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 apr 1987 Consegnato il 13 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the south west side of dealburn road, law moor, bradford, west yorkshire title no - wyk 288973. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 dic 1986 Consegnato il 19 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 31 mar 1982 Consegnato il 07 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
REDHEAD FREIGHT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0