KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01356836
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    • fabbricazione di prodotti in filo metallico, catene e molle (25930) / Industrie manifatturiere
    • fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici (27320) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PLESSEY WIRING SYSTEMS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    PLESSEY GROUP SERVICES LIMITED09 mar 197809 mar 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 apr 2016

    17 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Brook Point 1412-1420 High Road Whetstone London N20 9BH a 4 Stirling Court Stirling Way Borehamwood Herts WD6 2BT in data 19 ott 2015

    1 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 apr 2015

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 apr 2014

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 01 apr 2014

    8 pagine1.3

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    8 pagine1.4

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    22 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 Fleet Place London EC4M 7RD England* in data 11 apr 2013

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company place voluntary creditors liquidation/appoint liquidator 27/03/2013
    RES13

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 feb 2013

    Stato del capitale al 20 feb 2013

    • Capitale: GBP 2,718,215
    SH01

    Cessazione della carica di William Gimson come amministratore

    2 pagineTM01

    Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    23 pagineAA

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    8 pagine1.1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Richard Martin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Mckerrow come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    6 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Segretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2503744
    146855460001
    GIMSON, John Peter
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    Amministratore
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    EnglandBritish89639570001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    ELLARD, Sarah Louise
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    Segretario
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    British43855640009
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Segretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Segretario
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    British33089100003
    AUSTIN, Brian Sergio, Mr.
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish83674480001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWEN, Malcolm Alvin
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    British27471100001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    DAVIES, Arthur Thomas
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    Amministratore
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    British24258700001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritish4471420003
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Amministratore
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    GIMSON, William Peter Critchley
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United Kingdom British 162987980001
    HOLLAND, Richard Andrew
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish107177720001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    British69883500001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Amministratore
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    MARTIN, Richard
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish27471110004
    MCKERROW, Andrew James
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish83845420002
    MOLONY, Peter John
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    Amministratore
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    British42803990001
    RAINBIRD, Graham Dennis
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    British83845440002
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish45628680002
    RAYNER, Paul Adrian
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    British45628680001
    SHORE, David Alan
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish116529450001
    STOPPS, Ian Robert, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish154207190001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish33089100003

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 mar 2013
    Consegnato il 06 mar 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the charge holder on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property including goodwill, debts, uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Champlain Cable Corporation
    Transazioni
    • 06 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Full form debenture
    Creato il 04 lug 2011
    Consegnato il 19 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 ago 2010
    Consegnato il 25 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 25 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 set 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2003
    Consegnato il 15 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 14 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts
    Creato il 06 dic 1994
    Consegnato il 14 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over all book debts and other debts as from time to time be due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 06 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 dic 1989
    Consegnato il 02 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 lug 1988
    Consegnato il 21 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge as all book and otherdebts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 ago 1982
    Consegnato il 20 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First food charge over all book & other debts with 9 floating charge over (see doc 34). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1982Registrazione di un'ipoteca

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 lug 2012Data della riunione per approvare il CVA
    01 apr 2014Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Praticante
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    DataTipo
    17 apr 2013Inizio della liquidazione
    30 set 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Stephen Kelmanson
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Praticante
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Praticante
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0