COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01359521 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Countryside House The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
COUNTRYSIDE BUILD (SOUTHERN) LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
MADMILD LIMITED | 23 mar 1978 | 23 mar 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Neville Whitaker il 02 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ian Scott il 04 feb 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Stewart Cherry come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Ian Scott come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Stephen Cherry come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Stephen Cherry il 23 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARREN, Tracy Marina | Segretario | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||
SCOTT, Michael Ian | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | Financial Controller | 290228130001 | ||||
WHITAKER, Gary Neville | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | General Counsel | 238965410002 | ||||
HOYLES, Robin Patrick | Segretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||
PEARCE, Michael Frank | Segretario | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Segretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
CHERRY, Alan Herbert | Amministratore | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | Chartered Surveyor | 2026150001 | ||||
CHERRY, Graham Stewart | Amministratore | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Chief Executive | 7228590002 | ||||
CHERRY, Richard Stephen | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | Company Director | 68733260003 | ||||
PEARCE, Michael Frank | Amministratore | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | England | British | Chartered Accountant | 33032910001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside Properties (Uk) Limited | 06 apr 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 31 gen 1995 Consegnato il 21 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land at prospect royal edinburgh way harlow essex and the proceeds of sale thereof and goodwill of the company in connection of any business or businesses carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 14 giu 1993 Consegnato il 25 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property 19-37 (odd numbers only) goods station yard tunbridge wells and the proceeds of sale thereof, title no:- K678728 and an assignment of the goodwill and connection of any business,together with the full benefit of all licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 ott 1989 Consegnato il 20 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of any facility letter or other agreement or agreements (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 ott 1989 Consegnato il 11 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land with the buildings erected thereon or on some part or parts thereof situate at and fronting goods station road, and belgrave road, tunbridge wells, county of kent. K/a 19/37 (odd nos) goods station road, tunbridge wells, kent. T/n:- K607298. Together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 mag 1986 Consegnato il 20 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whtsoever. | |
Brevi particolari F/H land on the east side of oakhill road savenoaks, kent. Part of title no:- K470174. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 mag 1986 Consegnato il 20 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari F/H land on the east side of oakhill road sevenoaks, kent, title no:- k 470174 (part of). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 apr 1985 Consegnato il 30 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsover. | |
Brevi particolari Land and buildings known as 16A st. Johns road tunbridge wells kent title no. K 484471. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 mar 1985 Consegnato il 26 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the and/or countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 20 st john's road, tunbridge wells, kent title no. K 484471. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 02 nov 1984 Consegnato il 20 nov 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 33 & 35 eleanor cross road, waltham cross, broxbourne, hertfordshire title no. Hd 153666 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 nov 1984 Consegnato il 09 nov 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from countryside properties PLC on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H land on the southside of st james road brentwood, essex. Title no ex 262151. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 apr 1981 Consegnato il 21 apr 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 94 the heights,foxgrove rd.,beckenham borough of bramley title no.sgl 56991. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 24 lug 1980 Consegnato il 28 lug 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at the rear of birling road, tunbridge wells kent. (Nos 23-30 birling rd.) Title no. K 498489. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 set 1978 Consegnato il 02 ott 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land adjoining 14 castle street ongar essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0