COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED

COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01359521
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Countryside House The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUNTRYSIDE BUILD (SOUTHERN) LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    MADMILD LIMITED23 mar 197823 mar 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Neville Whitaker il 02 ago 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ian Scott il 04 feb 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Graham Stewart Cherry come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Ian Scott come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Stephen Cherry come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 apr 2016

    Stato del capitale al 21 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2015

    Stato del capitale al 24 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    1 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Stephen Cherry il 23 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2014

    Stato del capitale al 25 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    SCOTT, Michael Ian
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    United KingdomBritishFinancial Controller290228130001
    WHITAKER, Gary Neville
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    United KingdomBritishGeneral Counsel238965410002
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Segretario
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    British34860250001
    PEARCE, Michael Frank
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Segretario
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    British33032910001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    CHERRY, Alan Herbert
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    EnglandBritishChartered Surveyor2026150001
    CHERRY, Graham Stewart
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishChief Executive7228590002
    CHERRY, Richard Stephen
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68733260003
    PEARCE, Michael Frank
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant33032910001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    06 apr 2016
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00614864
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1995
    Consegnato il 21 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at prospect royal edinburgh way harlow essex and the proceeds of sale thereof and goodwill of the company in connection of any business or businesses carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 1993
    Consegnato il 25 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property 19-37 (odd numbers only) goods station yard tunbridge wells and the proceeds of sale thereof, title no:- K678728 and an assignment of the goodwill and connection of any business,together with the full benefit of all licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ott 1989
    Consegnato il 20 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of any facility letter or other agreement or agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Countryside Properties PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ott 1989
    Consegnato il 11 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land with the buildings erected thereon or on some part or parts thereof situate at and fronting goods station road, and belgrave road, tunbridge wells, county of kent. K/a 19/37 (odd nos) goods station road, tunbridge wells, kent. T/n:- K607298. Together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fraser & Partners Limited
    Transazioni
    • 11 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 1986
    Consegnato il 20 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whtsoever.
    Brevi particolari
    F/H land on the east side of oakhill road savenoaks, kent. Part of title no:- K470174.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 1986
    Consegnato il 20 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H land on the east side of oakhill road sevenoaks, kent, title no:- k 470174 (part of).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 1985
    Consegnato il 30 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsover.
    Brevi particolari
    Land and buildings known as 16A st. Johns road tunbridge wells kent title no. K 484471.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1985
    Consegnato il 26 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the and/or countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    20 st john's road, tunbridge wells, kent title no. K 484471.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 nov 1984
    Consegnato il 20 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    33 & 35 eleanor cross road, waltham cross, broxbourne, hertfordshire title no. Hd 153666 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 nov 1984
    Consegnato il 09 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from countryside properties PLC on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land on the southside of st james road brentwood, essex. Title no ex 262151.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1981
    Consegnato il 21 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 94 the heights,foxgrove rd.,beckenham borough of bramley title no.sgl 56991.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 24 lug 1980
    Consegnato il 28 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of birling road, tunbridge wells kent. (Nos 23-30 birling rd.) Title no. K 498489. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 set 1978
    Consegnato il 02 ott 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining 14 castle street ongar essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0