MTS GROUP HOLDINGS LIMITED

MTS GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMTS GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01359829
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MTS GROUP LIMITED05 ott 198705 ott 1987
    M.T.S. ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED28 mar 197828 mar 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 13 set 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced by £845 11/09/2012
    RES13

    legacy

    15 pagineMG01

    legacy

    15 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagineAD02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Burchall il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor70686070002
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Segretario
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishChartered Accountant26433460001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Segretario
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    British64640450003
    PIDGEON, Sandra Fay
    Swan Lodge
    14 The Avenue
    SL3 9DQ Datchet
    Berkshire
    Segretario
    Swan Lodge
    14 The Avenue
    SL3 9DQ Datchet
    Berkshire
    British39302350001
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Amministratore
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    BritishChartered Accountant26433460001
    BRAILEY, Geoffrey Ian
    2 Romaine Close
    RH15 0NS Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    2 Romaine Close
    RH15 0NS Burgess Hill
    West Sussex
    BritishChartered Accountant10317690001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Amministratore
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    EDEN, Roger Charles
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant41649520001
    LAKE, David Anthony
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Amministratore
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    EnglandBritishDirector59820940001
    MACDONALD, Philip
    Manor Farm
    Tollerton Lane
    NG12 Tollerton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Tollerton Lane
    NG12 Tollerton
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director39456670002
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Amministratore
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    United KingdomBritishDirector64640450003
    MCEWAN, Lindsay
    1 Annandale Drive
    GU10 3JD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    1 Annandale Drive
    GU10 3JD Farnham
    Surrey
    BritishDirector81641200001
    PIDGEON, Sandra Fay
    Swan Lodge
    14 The Avenue
    SL3 9DQ Datchet
    Berkshire
    Amministratore
    Swan Lodge
    14 The Avenue
    SL3 9DQ Datchet
    Berkshire
    BritishDirector39302350001
    ROOS, John Albert
    Beavers Beaver Lane
    Yateley
    GU17 7XJ Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Beavers Beaver Lane
    Yateley
    GU17 7XJ Camberley
    Surrey
    BritishManaging Director2690510001
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    Amministratore
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director11900790002
    SARSON, Michael Robert
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector27419330001

    MTS GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 23 ago 2012
    Consegnato il 28 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 08 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 apr 2007
    Consegnato il 12 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 27 apr 2007
    Consegnato il 02 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 giu 1994
    Consegnato il 20 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge by way of assignment
    Creato il 31 mar 1983
    Consegnato il 14 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease purchase agreements
    Brevi particolari
    The equipment in the attached schedule (for full details see doc M24).
    Persone aventi diritto
    • Concord Leasing Limited.
    Transazioni
    • 14 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 mar 1982
    Consegnato il 23 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 22 london road, the square, laughton, milton keynes.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    Agreement to assign
    Creato il 03 apr 1981
    Consegnato il 03 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master hire purchase agreement dated 3/4/81
    Brevi particolari
    The hirer assigns & agrees to assigns to the owner by way of security all of hirers rights title, benefit & interests toin a lease dated 3/4/81 including without limitation any moneys (including insurance proceeds whatsoever payable to or on account of the hirer under the lease & all other rights & benefits whatsoever thereby accassing to the hirer.
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited.
    Transazioni
    • 03 apr 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0