MTS GROUP HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MTS GROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01359829 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton Bedfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MTS GROUP LIMITED | 05 ott 1987 | 05 ott 1987 |
M.T.S. ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED | 28 mar 1978 | 28 mar 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Stato del capitale al 13 set 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 15 pagine | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 15 pagine | MG01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Burchall il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MTS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATSON, Rebecca Jane | Segretario | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | British | Solicitor | 70686070002 | |||||
BURCHALL, Andrew Jeremy | Amministratore | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 69904570002 | ||||
WATSON, Rebecca Jane | Amministratore | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | Solicitor | 70686070002 | ||||
ABRAHAMSON, John David | Segretario | 2 New End Square NW3 1LN London | British | Chartered Accountant | 26433460001 | |||||
MARTIN, Christopher Paul | Segretario | 15 Roxburghe Mansions 32 Kensington Court W8 5BQ London | British | 64640450003 | ||||||
PIDGEON, Sandra Fay | Segretario | Swan Lodge 14 The Avenue SL3 9DQ Datchet Berkshire | British | 39302350001 | ||||||
ABRAHAMSON, John David | Amministratore | 2 New End Square NW3 1LN London | British | Chartered Accountant | 26433460001 | |||||
BRAILEY, Geoffrey Ian | Amministratore | 2 Romaine Close RH15 0NS Burgess Hill West Sussex | British | Chartered Accountant | 10317690001 | |||||
DOYLE, Desmond Mark Christopher | Amministratore | Bagwell Lane RG29 1JG Odiham Green Hill Hampshire | England | British | Director | 266121440001 | ||||
EDEN, Roger Charles | Amministratore | Peters Court Plymouth Drive Barnt Green B45 8JB Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 41649520001 | ||||
LAKE, David Anthony | Amministratore | 66 Elm Park Road SW3 6AU London | England | British | Director | 59820940001 | ||||
MACDONALD, Philip | Amministratore | Manor Farm Tollerton Lane NG12 Tollerton Nottinghamshire | British | Company Director | 39456670002 | |||||
MARTIN, Christopher Paul | Amministratore | 15 Roxburghe Mansions 32 Kensington Court W8 5BQ London | United Kingdom | British | Director | 64640450003 | ||||
MCEWAN, Lindsay | Amministratore | 1 Annandale Drive GU10 3JD Farnham Surrey | British | Director | 81641200001 | |||||
PIDGEON, Sandra Fay | Amministratore | Swan Lodge 14 The Avenue SL3 9DQ Datchet Berkshire | British | Director | 39302350001 | |||||
ROOS, John Albert | Amministratore | Beavers Beaver Lane Yateley GU17 7XJ Camberley Surrey | British | Managing Director | 2690510001 | |||||
ROWLEY, John | Amministratore | Hickling Lodge Melton Road LE14 3QG Hickling Pastures Leicestershire | England | British | Company Director | 11900790002 | ||||
SARSON, Michael Robert | Amministratore | 12 Pine Grove Brookmans Park AL9 7BS Hatfield Hertfordshire | England | British | Director | 27419330001 |
MTS GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 23 ago 2012 Consegnato il 28 ago 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 08 ago 2012 Consegnato il 14 ago 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 06 mag 2008 Consegnato il 17 mag 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 27 apr 2007 Consegnato il 12 mag 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 27 apr 2007 Consegnato il 02 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the security trustee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 07 giu 1994 Consegnato il 20 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge by way of assignment | Creato il 31 mar 1983 Consegnato il 14 apr 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease purchase agreements | |
Brevi particolari The equipment in the attached schedule (for full details see doc M24). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 11 mar 1982 Consegnato il 23 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 22 london road, the square, laughton, milton keynes.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Agreement to assign | Creato il 03 apr 1981 Consegnato il 03 apr 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master hire purchase agreement dated 3/4/81 | |
Brevi particolari The hirer assigns & agrees to assigns to the owner by way of security all of hirers rights title, benefit & interests toin a lease dated 3/4/81 including without limitation any moneys (including insurance proceeds whatsoever payable to or on account of the hirer under the lease & all other rights & benefits whatsoever thereby accassing to the hirer. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0