DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED

DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01363817
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    • Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia e l'ingegneria civile (77320) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    Note
    DataNota
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Anthony Guzzi come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 ago 2013

    SH01
    Note
    DataNota
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher John Howse come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Thameside Centre Kew Bridge Road Kew Bridge Middlesex TW8 0HF* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Note
    DataNota
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cessazione della carica di John Matthews come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Frank Macinnis come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony J Guzzi come amministratore

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Note
    DataNota
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Note
    DataNota
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG04

    Chi sono gli amministratori di DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALKER, Michael Lawrence
    159 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EE London
    Segretario
    159 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EE London
    British33962790001
    CHANTER, Keith
    KT23
    Amministratore
    KT23
    United KingdomBritish126079170001
    HOWSE, Christopher John
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish58746330001
    WHARTON, Richard Humphrey
    Byways
    Southampton Road
    SP5 3AF Alderbury
    Wiltshire
    Segretario
    Byways
    Southampton Road
    SP5 3AF Alderbury
    Wiltshire
    British37348500001
    BRITTON, Graham
    Millstream
    Lower Peover
    WA16 9QD Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Millstream
    Lower Peover
    WA16 9QD Knutsford
    Cheshire
    British34559340001
    CRITCHLOW, Norman James
    19 Danehurst Close
    TW20 9PX Egham
    Surrey
    Amministratore
    19 Danehurst Close
    TW20 9PX Egham
    Surrey
    United KingdomBritish67957920001
    DAVIES, Brian John
    11 Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    11 Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British30176020003
    DAVIS, Martin Kennett
    212 Clive Road
    West Dulwich
    SE21 8BS London
    Amministratore
    212 Clive Road
    West Dulwich
    SE21 8BS London
    United KingdomBritish16398050001
    DWYER, Andrew Thompson
    532 Catitoe Road
    FOREIGN Bedford
    New York
    Usa
    Amministratore
    532 Catitoe Road
    FOREIGN Bedford
    New York
    Usa
    American16258580001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Amministratore
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritish73774260004
    GOSCOMB, Christopher Roderick John
    Chichele Cottage
    11 Chichele Road
    RH8 0AE Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Chichele Cottage
    11 Chichele Road
    RH8 0AE Oxted
    Surrey
    UkBritish1610330001
    GRENDI, Ernest Walter
    57 Harbor Hill Drive
    FOREIGN Lloyd Harbor
    New York 11743
    Usa
    Amministratore
    57 Harbor Hill Drive
    FOREIGN Lloyd Harbor
    New York 11743
    Usa
    American13328320001
    GUZZI, Anthony J
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican167510820001
    KORNFELD, Stephen
    17 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Amministratore
    17 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British35561690002
    KOSNIK, Edward Francis
    9 Ashton Drive
    06831 Greenwich
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    9 Ashton Drive
    06831 Greenwich
    Connecticut
    Usa
    Us Citizen35862160001
    MACINNIS, Frank Thomas
    7 Sturges Hollow
    IRISH Westport
    Connecticut 06880
    Usa
    Amministratore
    7 Sturges Hollow
    IRISH Westport
    Connecticut 06880
    Usa
    UsaCanadian40058020001
    MATTHEWS, John
    Springhill Cottage
    Foxlydiate Lane Webheath
    B97 5PB Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Springhill Cottage
    Foxlydiate Lane Webheath
    B97 5PB Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish93708330001
    MOORE, Clive Alan
    239 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    Amministratore
    239 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    British37447250001
    WEST, John Vaughan Chanler
    63 Pasture Road
    SG6 3LS Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    63 Pasture Road
    SG6 3LS Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30124410001
    WHALE, Anthony Roger
    Hadleigh 8 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hadleigh 8 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British41878460001

    DELCOMMERCE (CONTRACT SERVICES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 gen 2006
    Consegnato il 24 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Harris N.A. as Agent and Security Trustee for the Lenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 05 nov 2002
    Consegnato il 07 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all the plant, machinery, fixtures and fittings now and in the future belonging to the chargor and all right, title and interest of the chargor under any agreements now and in the future relating to the purchase, lease or hire purchase of the same, subject to reassignment on redemption... See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harris Trust and Savings Bank as Agent and Security Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 07 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 apr 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Deed of reaffirmation and accession
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers (as therein defined) to the chargee under the credit agreement dated 19 june 1996 and all sums due under a guarantee dated 29 october 1997
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harris Trust & Savings Bank(Ag Agent)
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General debenture
    Creato il 29 ott 1997
    Consegnato il 30 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under a credit agreement dated 19TH june 1997
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harris Trust & Savings Bank (As Agent for the Lenders) as Collateral Agent
    Transazioni
    • 30 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 1993
    Consegnato il 27 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 1993
    Consegnato il 28 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Seaboard Surety Company
    Transazioni
    • 28 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0