SG LEASING (UTILITIES) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SG LEASING (UTILITIES) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01364426 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BMI (NO.3) LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| DANNYWELANT LIMITED | 21 apr 1978 | 21 apr 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2022 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 104 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 04 lug 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 14 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 14 lug 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lindsay Ginnette Sides come amministratore in data 04 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom a C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG a One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG in data 18 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 30 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Shields come amministratore in data 20 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Donald Cook come amministratore in data 05 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Lethbridge Fowler il 20 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr. Paul Shields come amministratore in data 19 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALINSKA-JUNDZILL, Catherine | Segretario | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | 191477830001 | |||||||
| DENT, Nicholas Michael | Amministratore | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | United Kingdom | British | 43922780002 | |||||
| FOWLER, Stephen Lethbridge | Amministratore | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | England | British | 135237620002 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Segretario | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Segretario | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Segretario | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| AKRAM, Mohammed | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169142800001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Amministratore | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Amministratore | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Amministratore | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Amministratore | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| COOK, Stuart Donald | Amministratore | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | United Kingdom | British | 191477240004 | |||||
| DOWDING, Eric Robert | Amministratore | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Amministratore | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| EVANS, Christopher Hewitt | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 121774150001 | ||||||
| HARE, Darren Mark | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 127470250001 | |||||
| HUCKLE, Jonathan Mark | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 163223760001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| LEWIS, Barry Randall | Amministratore | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Amministratore | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| MILES, Martin Graham | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 108439150001 | |||||
| MILLINER, Craig | Amministratore | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| NIMMO, Mark Alexander | Amministratore | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | England | British | 33420600001 | |||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROSE, Stephen George | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 143870380001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Amministratore | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| SHIELDS, Paul | Amministratore | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg | England | British | 244361960001 | |||||
| SIDES, Lindsay Ginnette | Amministratore | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 212141970001 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Amministratore | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIMPSON, Gavin John | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 149333050001 | |||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | Irish | 122291210001 | |||||
| WEAL, Barry | Amministratore | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Amministratore | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale | 06 apr 2016 | Boulevard Haussmann 75009 Paris 29 France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Secondary lease security assignment | Creato il 30 dic 1992 Consegnato il 14 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92 | |
Brevi particolari All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Sub-lessee security agreement | Creato il 30 dic 1992 Consegnato il 14 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92 | |
Brevi particolari All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First priority statutory mortgage | Creato il 18 dic 1986 Consegnato il 07 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86 | |
Brevi particolari 64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenant | Creato il 18 dic 1986 Consegnato il 07 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed | |
Brevi particolari The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Financial agreement | Creato il 11 ott 1985 Consegnato il 14 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985 | |
Brevi particolari All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shipowners agreement | Creato il 01 ott 1985 Consegnato il 14 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement | |
Brevi particolari Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenant | Creato il 18 mar 1985 Consegnato il 03 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Brevi particolari All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First priority statutory mortgage | Creato il 18 mar 1985 Consegnato il 03 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Brevi particolari 64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 28 feb 1985 Consegnato il 12 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985 | |
Brevi particolari All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0