SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSG LEASING (UTILITIES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01364426
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BMI (NO.3) LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    DANNYWELANT LIMITED21 apr 197821 apr 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2022

    7 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 04 lug 2022

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 14 dic 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 14 lug 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 giu 2021

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Cessazione della carica di Lindsay Ginnette Sides come amministratore in data 04 giu 2021

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom a C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG a One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG in data 18 nov 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul Shields come amministratore in data 20 mag 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stuart Donald Cook come amministratore in data 05 apr 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Lethbridge Fowler il 20 set 2018

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr. Paul Shields come amministratore in data 19 mar 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Segretario
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    191477830001
    DENT, Nicholas Michael
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritish135237620002
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Segretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Segretario
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Amministratore
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    COOK, Stuart Donald
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish191477240004
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish163223760001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Amministratore
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SHIELDS, Paul
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Amministratore
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish244361960001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    Amministratore
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    EnglandBritish212141970001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Société Générale
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    06 apr 2016
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    No
    Forma giuridicaSociété Anonyme (French Public Limited Company)
    Paese di registrazioneFrance
    Autorità legaleFrench Monetary And Financial Code And French Commercial Code
    Luogo di registrazioneRegistre Du Commerce Et Des Sociétés - Greffe Du Tribunal De Commerce De Paris (Infogreffe - Les Greffes Des Tribunaux De Commerce)
    Numero di registrazione552 120 222 00013 (Trade Register: 552 120 222 R.C.S. Paris)
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Secondary lease security assignment
    Creato il 30 dic 1992
    Consegnato il 14 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sub-lessee security agreement
    Creato il 30 dic 1992
    Consegnato il 14 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92
    Brevi particolari
    All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transazioni
    • 14 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Creato il 18 dic 1986
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86
    Brevi particolari
    64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 18 dic 1986
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed
    Brevi particolari
    The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Financial agreement
    Creato il 11 ott 1985
    Consegnato il 14 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985
    Brevi particolari
    All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Shipowners agreement
    Creato il 01 ott 1985
    Consegnato il 14 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement
    Brevi particolari
    Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36).
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 14 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 18 mar 1985
    Consegnato il 03 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85
    Brevi particolari
    All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transazioni
    • 03 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Creato il 18 mar 1985
    Consegnato il 03 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85
    Brevi particolari
    64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transazioni
    • 03 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 28 feb 1985
    Consegnato il 12 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985
    Brevi particolari
    All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank.
    Transazioni
    • 12 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 giu 2021Inizio della liquidazione
    21 ott 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0