SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED

SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01364907
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    • Attività combinate di servizi amministrativi d'ufficio (82110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELMHAVENS LIMITED25 apr 197825 apr 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Richard John Wilkinson come amministratore in data 19 giu 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard John Wilkinson come segretario in data 19 giu 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Keith Fairbrass come amministratore in data 19 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Keith Fairbrass come segretario in data 19 giu 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2015

    Stato del capitale al 27 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Vitacress Ltd Stoneham Gate Stoneham Lane Eastleigh Hampshire SO50 9NW United Kingdom a Runcton Nursery Lagness Road Runcton Chichester West Sussex PO20 1LJ

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2014

    Stato del capitale al 05 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas Stenning come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Toby John Brinsmead come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Mr Keith Fairbrass come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Keith Fairbrass come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Wilson come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Wilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKINSON, Richard John
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    Segretario
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    198774070001
    BRINSMEAD, Toby John
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    EnglandBritishDirector141000110001
    ROTHWELL, Steven Denis
    The Birches
    Goscombe Lane, Gundleton
    SO24 9SP Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    The Birches
    Goscombe Lane, Gundleton
    SO24 9SP Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishMd Production Division31607480007
    WILKINSON, Richard John
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Lowerlink Farm
    Lower Link, St. Mary Bourne
    SP11 6DB Andover
    Hampshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director198772640001
    DAVIS, John Nelder
    12 Heathcote Place
    Hursley
    SO21 2LH Winchester
    Hampshire
    Segretario
    12 Heathcote Place
    Hursley
    SO21 2LH Winchester
    Hampshire
    BritishFinance Director8375410001
    FAIRBRASS, Keith
    Beech Hill
    Headley Down
    GU35 8EG Bordon
    Fuller's Cottage
    Hampshire
    England
    Segretario
    Beech Hill
    Headley Down
    GU35 8EG Bordon
    Fuller's Cottage
    Hampshire
    England
    176388720001
    WILSON, Mark Alastair, Mr.
    17 Mount Hermon Road
    GU22 7TT Woking
    Surrey
    Segretario
    17 Mount Hermon Road
    GU22 7TT Woking
    Surrey
    BritishFinance Director87016700001
    DAVIS, John Nelder
    12 Heathcote Place
    Hursley
    SO21 2LH Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    12 Heathcote Place
    Hursley
    SO21 2LH Winchester
    Hampshire
    BritishDirector8375410001
    FAIRBRASS, Keith
    Beech Hill
    Headley Down
    GU35 8EG Bordon
    Fuller's Cottage
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Beech Hill
    Headley Down
    GU35 8EG Bordon
    Fuller's Cottage
    Hampshire
    England
    EnglandBritishFinance Director176388000001
    ISAAC, Jill Elisabeth
    Abbey House
    Warnford
    SO32 3LB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Abbey House
    Warnford
    SO32 3LB Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector8375430001
    ISAAC, Malcolm John
    Abbey House
    Warnford
    SO32 3LB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Abbey House
    Warnford
    SO32 3LB Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director8258100001
    STENNING, Nicholas Julian Seymour
    Medstead House
    GU34 5LY Medstead
    Hampshire
    Amministratore
    Medstead House
    GU34 5LY Medstead
    Hampshire
    EnglandBritishCeo87218210001
    WATTS, John Robert William
    5-6 Hollow Oak
    Bere Regis
    BH20 7LR Wareham
    Dorset
    Amministratore
    5-6 Hollow Oak
    Bere Regis
    BH20 7LR Wareham
    Dorset
    BritishDirector8957270001
    WILSON, Mark Alastair, Mr.
    17 Mount Hermon Road
    GU22 7TT Woking
    Surrey
    Amministratore
    17 Mount Hermon Road
    GU22 7TT Woking
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director87016700001

    SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 27 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being part of manor farm cressbeds roke road bere regis dorset by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 27 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-the hollybush cressbeds and bungalow roke road bere regis dorset by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1979
    Consegnato il 14 feb 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate at bere regis, dorset, comprised in a conveyance dated 29.12.78.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0