SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED
Panoramica
Nome della società | SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01364907 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
- Attività combinate di servizi amministrativi d'ufficio (82110) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Lowerlink Farm Lower Link, St. Mary Bourne SP11 6DB Andover Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ELMHAVENS LIMITED | 25 apr 1978 | 25 apr 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Richard John Wilkinson come amministratore in data 19 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard John Wilkinson come segretario in data 19 giu 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Fairbrass come amministratore in data 19 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Fairbrass come segretario in data 19 giu 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Vitacress Ltd Stoneham Gate Stoneham Lane Eastleigh Hampshire SO50 9NW United Kingdom a Runcton Nursery Lagness Road Runcton Chichester West Sussex PO20 1LJ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Stenning come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Toby John Brinsmead come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Keith Fairbrass come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Keith Fairbrass come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Wilson come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Wilson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKINSON, Richard John | Segretario | Lowerlink Farm Lower Link, St. Mary Bourne SP11 6DB Andover Hampshire | 198774070001 | |||||||
BRINSMEAD, Toby John | Amministratore | Lowerlink Farm Lower Link, St. Mary Bourne SP11 6DB Andover Hampshire | England | British | Director | 141000110001 | ||||
ROTHWELL, Steven Denis | Amministratore | The Birches Goscombe Lane, Gundleton SO24 9SP Alresford Hampshire | United Kingdom | British | Md Production Division | 31607480007 | ||||
WILKINSON, Richard John | Amministratore | Lowerlink Farm Lower Link, St. Mary Bourne SP11 6DB Andover Hampshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 198772640001 | ||||
DAVIS, John Nelder | Segretario | 12 Heathcote Place Hursley SO21 2LH Winchester Hampshire | British | Finance Director | 8375410001 | |||||
FAIRBRASS, Keith | Segretario | Beech Hill Headley Down GU35 8EG Bordon Fuller's Cottage Hampshire England | 176388720001 | |||||||
WILSON, Mark Alastair, Mr. | Segretario | 17 Mount Hermon Road GU22 7TT Woking Surrey | British | Finance Director | 87016700001 | |||||
DAVIS, John Nelder | Amministratore | 12 Heathcote Place Hursley SO21 2LH Winchester Hampshire | British | Director | 8375410001 | |||||
FAIRBRASS, Keith | Amministratore | Beech Hill Headley Down GU35 8EG Bordon Fuller's Cottage Hampshire England | England | British | Finance Director | 176388000001 | ||||
ISAAC, Jill Elisabeth | Amministratore | Abbey House Warnford SO32 3LB Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Director | 8375430001 | ||||
ISAAC, Malcolm John | Amministratore | Abbey House Warnford SO32 3LB Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Managing Director | 8258100001 | ||||
STENNING, Nicholas Julian Seymour | Amministratore | Medstead House GU34 5LY Medstead Hampshire | England | British | Ceo | 87218210001 | ||||
WATTS, John Robert William | Amministratore | 5-6 Hollow Oak Bere Regis BH20 7LR Wareham Dorset | British | Director | 8957270001 | |||||
WILSON, Mark Alastair, Mr. | Amministratore | 17 Mount Hermon Road GU22 7TT Woking Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 87016700001 |
SYLVASPRINGS WATERCRESS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creato il 07 feb 1997 Consegnato il 27 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being part of manor farm cressbeds roke road bere regis dorset by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 07 feb 1997 Consegnato il 27 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-the hollybush cressbeds and bungalow roke road bere regis dorset by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 gen 1979 Consegnato il 14 feb 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land situate at bere regis, dorset, comprised in a conveyance dated 29.12.78. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0