SHOWELLS (GARAGES) LIMITED

SHOWELLS (GARAGES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHOWELLS (GARAGES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01366295
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    109 Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    Loughborogh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    I.M. VEHICLE SALES LIMITED13 apr 200413 apr 2004
    SHOWELLS (GARAGES) LIMITED03 mag 197803 mag 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagineLIQ14

    Soddisfazione dell'onere 013662950007 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Far Moor Lane Farmoor Lane Coventry Highway Redditch Worcestershire B98 0SD a 109 Swan Street Sileby Loughborogh DY8 1LT in data 02 ott 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 23 set 2019

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 013662950008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 013662950009 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gerald Peter Freeman il 01 lug 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2016, revisionato

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Timothy Gerald Freeman come amministratore in data 20 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2015

    Stato del capitale al 30 ott 2015

    • Capitale: GBP 900
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di John Bentley come amministratore in data 24 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter George Bernard Freeman come amministratore in data 25 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 ott 2014

    Stato del capitale al 31 ott 2014

    • Capitale: GBP 900
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FREEMAN, Elizabeth Ann
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    Segretario
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    180063990001
    FREEMAN, Gerald Peter
    Farmoor Lane
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Farmoor Lane
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    United KingdomBritishCompany Director10465870008
    FREEMAN, Timothy Gerald
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    Amministratore
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    EnglandBritishDealer Principal178938750003
    GEOBEY, Mark Anthony
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    Amministratore
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    EnglandBritishFinancial Director174089060001
    NAPIER, David Leslie John
    4 Victoria Way
    Coleshill
    B46 3FD Birmingham
    Segretario
    4 Victoria Way
    Coleshill
    B46 3FD Birmingham
    OtherCompany Secretary26166850014
    SHOWELL, Brian
    18 Eggington Road
    Wollaston
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    18 Eggington Road
    Wollaston
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    British16549450002
    BENTLEY, John
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    Amministratore
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    EnglandBritishOperations Director182199210001
    BROWNING, Robert John
    Ouseley Barns
    Aston Eyre Morville
    WV16 6XD Bridgnorth
    Salop
    Amministratore
    Ouseley Barns
    Aston Eyre Morville
    WV16 6XD Bridgnorth
    Salop
    United KingdomBritishDirector40686630001
    EDMISTON, Andrew Martin
    B46
    Amministratore
    B46
    EnglandBritishDirector169617200001
    FREEMAN, Elizabeth Ann
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    EnglandBritishCompany Secretary179996580001
    FREEMAN, Peter George Bernard
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    EnglandBritishCompany Director10465860002
    GOOD, Lawrence David
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Farmoor Lane
    Coventry Highway
    B98 0SD Redditch
    Far Moor Lane
    Worcestershire
    England
    United KingdomBritishCompany Director148638300001
    SHOWELL, Brian
    18 Eggington Road
    Wollaston
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    18 Eggington Road
    Wollaston
    DY8 4QJ Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishGeneral Manager16549450002
    SHOWELL, David
    78 Chapel Street
    Wordsley
    DY8 5QP Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    78 Chapel Street
    Wordsley
    DY8 5QP Stourbridge
    West Midlands
    BritishGarage Manager16549480001
    SHOWELL, John James
    61 Six Ashes Road
    Bobbington
    DY7 5BZ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    61 Six Ashes Road
    Bobbington
    DY7 5BZ Stourbridge
    West Midlands
    BritishGarage Proprietor16549470001
    SHOWELL, Mark
    Kazamardi Callow Hill
    Rock
    DY14 9XW Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Kazamardi Callow Hill
    Rock
    DY14 9XW Kidderminster
    Worcestershire
    BritishManager16549490003
    SHOWELL, Peter
    16490 Les Brechavaux
    Allove
    16490
    Amministratore
    16490 Les Brechavaux
    Allove
    16490
    BritishGarage Manager16549460005

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHOWELLS (GARAGES) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Gerald Peter Freeman
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    06 apr 2016
    Swan Street
    DY8 1LT Sileby
    109
    Loughborogh
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SHOWELLS (GARAGES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2014
    Consegnato il 13 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Fce Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2014
    Consegnato il 13 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All freehold and leasehold property at the date of the charge or at any time thereafter belonging to or charged to the chargor together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon and/or the proceeds of sale thereof.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Fce Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2013
    Consegnato il 29 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 29 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mar 2010
    Consegnato il 25 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 78 stourbridge road lye stourbridge west midlands t/no WM854229 WM432575 and WM738973 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Motors Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 gen 2010
    Consegnato il 08 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (previously known as I.M. vehicle sales limited) to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, equipment, investments. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Motors Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 2001
    Consegnato il 02 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    66 and 68 stourbridge road and 1 & 2 engine lane lye stourbridge west midlands. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 1997
    Consegnato il 29 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 1989
    Acquisito il 25 feb 2005
    Consegnato il 15 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the land and buildings at 78-82 stourbridge road lye stourbridge and all other property now vested in the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2005Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 22 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1988
    Consegnato il 15 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fair field garage, franche road, walverley, kidderminster in the county of hereford & worcester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHOWELLS (GARAGES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 set 2019Inizio della liquidazione
    08 ott 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nigel Price
    13 Church Street
    DY8 1LT Stourbridge
    West Midlands
    Praticante
    13 Church Street
    DY8 1LT Stourbridge
    West Midlands
    Joseph Gordon Maurice Sadler
    14 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    14 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0