CARILLION (AM) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARILLION (AM) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01367044 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION (AM) LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CARILLION (AM) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION (AM) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE LIMITED | 12 feb 2008 | 12 feb 2008 |
| ALFRED MCALPINE PLC | 04 feb 1985 | 04 feb 1985 |
| MARCHWIEL PLC | 08 mag 1978 | 08 mag 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION (AM) LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION (AM) LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 apr 2019 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 01 mag 2019 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 apr 2018 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION (AM) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 23 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Plc come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 09 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 25 giu 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Robin Herzberg come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Westley Maffei come segretario in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 35 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 31 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 giu 2015
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARILLION (AM) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT, Gordon George | Segretario | Farhills Flaxyards Woodfall Lane Little Neston CH64 4BT South Wirral | British | 62493790001 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Segretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 169859060001 | |||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Segretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Segretario | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 243236460001 | |||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Westgate Noctorum Lane,Noctorum L43 9UA Wirral Merseyside | British | 1195620001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| ALEXANDER, Alex Sandor, Sir | Amministratore | 13/14 Bryanston Square W1H 7FF London | British | 37193160001 | ||||||
| BALDWIN, Richard Keith, Dr | Amministratore | The Shaugh TN7 4DP Upper Hartfield East Sussex | United Kingdom | British | 37207590001 | |||||
| BOOTH, Karen Jane | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BRIGGS, William Noel | Amministratore | 101 Woodland Circle Cheraw South Carolina 29520 FOREIGN Usa | British | 49218370001 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Amministratore | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CLARK, Robert Anthony, Sir | Amministratore | Munstead Wood Heath Lane GU7 1UN Godalming Surrey | United Kingdom | British | 33624910001 | |||||
| COLLINS, Christopher Douglas | Amministratore | Hawthorn Farm HP16 0RL Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 3004530001 | |||||
| FORTIN, Richard Chalmers Gordon | Amministratore | 5 Dealtry Road Putney SW15 6NL London | British | 31479720001 | ||||||
| GREENWOOD, Mark | Amministratore | The Rubble Hole Little London Kings Court GL5 5DX Stroud | British | 98276400001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Amministratore | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| GROVE, Eric William | Amministratore | The Rye House Catesby Lane Lapworth B94 5QY Solihull West Midlands | England | British | 632880001 | |||||
| HARRISON, Terence, Sir | Amministratore | 2 The Garden House NE61 3UZ Whalton Northumberland | British | 7573800003 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HIGNETT, John Mulock | Amministratore | Flat 3 44 Lowndes Square SW1X 9JT London | British | 12746100002 | ||||||
| HOUGH, Robert Eric | Amministratore | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | 38776360001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HULMES, Peter Mcphee | Amministratore | 5 Badgers Close Christleton CH3 7BR Chester Cheshire | England | British | 17198990001 | |||||
| HUME, Jeffrey | Amministratore | 38 Burdon Lane SM2 7PT Cheam Surrey | United Kingdom | British | 58948740002 | |||||
| HURCOMB, David Stuart | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 34516340004 | |||||
| KENNY, Thomas Donald | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 85390230002 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KITSON, Timothy Peter Geoffrey, Sir | Amministratore | Leases Hall Leeming Bar DL7 9DE Northallerton North Yorkshire | British | 2761930001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Amministratore | Sneyd Lane WV11 2DX Essington, Wolverhampton 153 United Kingdom | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| LEVER, Kenneth | Amministratore | 47 Burgess Wood Road South HP9 1EL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 50134030001 | ||||||
| MCALPINE, Euan James | Amministratore | Lower Carden Hall SY14 7HW Malpas Cheshire | United Kingdom | British | 57585880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION (AM) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Plc | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CARILLION (AM) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of sub-charge | Creato il 02 mar 1993 Consegnato il 04 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due rom the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 26 february 1993. | |
Brevi particolari The legal charge dated 11 june 1990 registered on 6 july 1990 as entry 10 in the charges register of t/n NN85407 together with all assignment of all monies realised by alfred mcalpine PLC from any enforcement of the principal charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 08 set 1992 Consegnato il 17 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement of evendate. | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the securities specified as being 21,666,877 'a' ordinary shares of 25 pence each in the capital of alfred mcalpine developments limited see relevant form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CARILLION (AM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0