CLOSE NUMBER 17 PLC

CLOSE NUMBER 17 PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLOSE NUMBER 17 PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01367520
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLOSE NUMBER 17 PLC?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Indirizzo della sede legale
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUNSET HOLIDAYS PLC09 mag 197809 mag 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71
    A31OSXI1

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    A2GABJ3S

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A2GABJ44

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sunset holidays PLC\certificate issued on 18/07/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name18 lug 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 18 lug 2013

    RES15
    change-of-name18 lug 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    X2CUE877

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2013

    Stato del capitale al 26 giu 2013

    • Capitale: GBP 157,500
    SH01
    X2BBXE3L

    Nomina di Ms Shirley Bradley come amministratore

    2 pagineAP01
    X2AR99AA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    8 pagineAA
    A27679OP

    Nomina di Nigel John Arthur come amministratore

    2 pagineAP01
    X25XY7BM

    Cessazione della carica di Julia Seary come amministratore

    1 pagineTM01
    X25XY7AQ

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X1BVQXX4

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    8 pagineAA
    A15B2NEQ

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X0LZWVCK

    Cessazione della carica di Christopher Gadsby come amministratore

    1 pagineTM01
    XI6X9TUE

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    9 pagineAA
    ATIWESRE

    Nomina di Julia Louise Seary come amministratore

    2 pagineAP01
    X0V4XSF0

    Cessazione della carica di David Hallisey come amministratore

    1 pagineTM01
    X0V4VSFY

    Nomina di Ms Shirley Bradley come segretario

    1 pagineAP03
    XFCC1QOF

    Cessazione della carica di David Hallisey come segretario

    1 pagineTM02
    XFCC0QOE

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher James Gadsby il 22 nov 2010

    2 pagineCH01
    X0NT2PBF

    Nomina di Thomas Cook Group Management Services Limited come amministratore

    2 pagineAP02
    XRVK4OLG

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XXUC9L82

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    10 pagineAA
    PHRAQIL0

    Dettagli del segretario cambiati per Mr David Michael William Hallisey il 06 nov 2009

    1 pagineCH03
    XXLM8EQD

    Chi sono gli amministratori di CLOSE NUMBER 17 PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, Shirley
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    156767350001
    ARTHUR, Nigel John
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandEnglishCompany Director175689210001
    BRADLEY, Shirley
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director65475670001
    THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3696823
    146474110001
    DAVIS, Gary William
    78 Carrwood
    Hale Barns
    WA15 0ES Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    78 Carrwood
    Hale Barns
    WA15 0ES Altrincham
    Cheshire
    British97273690001
    HALLISEY, David Michael William
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    British1919030001
    PATTISON, Philip Richard
    Mowbray 314 Leigh Road
    Worsley
    M28 4QV Manchester
    Segretario
    Mowbray 314 Leigh Road
    Worsley
    M28 4QV Manchester
    British52152510001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Segretario
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    BritishFinance Director48949090001
    STEWART, Alan James
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    Segretario
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    BritishDirector62877180001
    AILLES, Ian Simon
    Commonwealth House
    Chicago Avenue
    M90 3FL Manchester
    Amministratore
    Commonwealth House
    Chicago Avenue
    M90 3FL Manchester
    EnglandBritishDirector69582910005
    GADSBY, Christopher James
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director118396090002
    HALLISEY, David Michael William
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishSolicitor1919030001
    HARDS, Nigel Richard
    Bower Fold
    38 Sunningdale Orton Waterville
    PE2 5UB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Bower Fold
    38 Sunningdale Orton Waterville
    PE2 5UB Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishChief Exec Uk And Ireland Trav49058100001
    KEVIN, John
    103 Dunster Drive
    Urmston
    M41 6WR Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    103 Dunster Drive
    Urmston
    M41 6WR Manchester
    Lancashire
    BritishCommercial Director70330620001
    MEREDITH, Norman
    6 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    6 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    BritishProduct Director54737000002
    MORGAN, Hugh
    26 White Hart Wood
    TN13 1RR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    26 White Hart Wood
    TN13 1RR Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector45813740002
    MULLER, Jeremy Howard
    Queens Lodge
    42 Great North Road
    N6 4LU London
    Uk
    Amministratore
    Queens Lodge
    42 Great North Road
    N6 4LU London
    Uk
    EnglandBritishCompany Director52081110001
    MULLIGAN, Amanda
    25 Collingwood Drive
    Swinton
    M27 5LW Manchester
    Amministratore
    25 Collingwood Drive
    Swinton
    M27 5LW Manchester
    BritishOperations Director39539900001
    PATTISON, Dianne
    Breeze Hill House Breeze Hill Road
    Atherton
    M29 9HJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Breeze Hill House Breeze Hill Road
    Atherton
    M29 9HJ Manchester
    Lancashire
    BritishTravel Agent17893290001
    PATTISON, Philip Richard
    Mowbray 314 Leigh Road
    Worsley
    M28 4QV Manchester
    Amministratore
    Mowbray 314 Leigh Road
    Worsley
    M28 4QV Manchester
    BritishChief Executive52152510001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Amministratore
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director48949090001
    SEARY, Julia Louise
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishLegal Director158190160001
    SHEPHERD, Elaine
    58 Sunnybank Road
    Bowdon
    WA14 3PW Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    58 Sunnybank Road
    Bowdon
    WA14 3PW Altrincham
    Cheshire
    BritishCustomer Services Director44319270001
    STEWART, Alan James
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    Amministratore
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    BritishDirector62877180001
    STEWART, Alan James
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    Amministratore
    Little Chantersluer
    Smalls Hill Road
    RH6 0HR Norwood Hill
    Surrey
    BritishDirector62877180001
    THOMAS, Glyn Collen
    12 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer4170780002
    UNWIN, David Howard
    Hatton House Hatton Hall Lane
    Hatton Heath
    CH3 9AP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Hatton House Hatton Hall Lane
    Hatton Heath
    CH3 9AP Chester
    Cheshire
    BritishAviation And Operations Direct55420040001
    UNWIN, Vivien
    Silver How
    Chatsworth Rd
    Worsley
    Salford
    Amministratore
    Silver How
    Chatsworth Rd
    Worsley
    Salford
    BritishTravel Agent17893280001
    VINCENT, Simon Robert
    Dorset Cottage
    18 Oak Road
    KT11 3AZ Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Dorset Cottage
    18 Oak Road
    KT11 3AZ Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector102638930001
    WINTERBURN, Garry
    80 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DP Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    80 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DP Warrington
    Cheshire
    BritishSales Director64949760001

    CLOSE NUMBER 17 PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 08 gen 1993
    Consegnato il 15 gen 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposit(s) deposited or paid by the chargor with or to the bank on behalf of the chargor (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 13 nov 1990
    Consegnato il 20 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of sterling pounds 200000 credited to the account number/designation 12783529 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 10 lug 1990
    Consegnato il 18 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of sterling pounds 445,000 credited to a/c no designation 12783502 with the bank together with all sums in the future credited to that account & including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of cash deposit
    Creato il 10 mar 1988
    Consegnato il 14 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit of sterling pounds 100,000 on account number 12783529 with the bank including all future interest accuring on the deposit (see form 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of cash deposit
    Creato il 23 set 1986
    Consegnato il 25 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit of sterling pounds 272500 on a/c no 12954900 with the bank including all future interest accruing on the deposit (see doc 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge of cash deposit
    Creato il 24 mar 1986
    Consegnato il 03 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit balance of sterling pounds 100,000 on account no 12954897 held by the company with the bank including all interest accrued or accruing in the future on the deposit and all increases in the amount of the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1986Registrazione di un'ipoteca

    CLOSE NUMBER 17 PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 2013Inizio della liquidazione
    18 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0