LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01367545 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ernst & Young Llp 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RAIDSOUTH LIMITED | 10 mag 1978 | 10 mag 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 dic 2020 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lloyds Secretaries Limited come segretario in data 08 set 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 dic 2019 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 dic 2018 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 8 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 25 Gresham Street London EC2V 7HN a Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF in data 25 gen 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 25 Gresham Street London EC2V 7HN | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 25 Gresham Street London EC2V 7HN | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew John Kemp come amministratore in data 09 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Owen Williams come amministratore in data 19 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michelle Antoinette Angela Johnson come segretario in data 23 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Lloyds Secretaries Limited come segretario in data 23 mar 2016 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Owen Williams il 06 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWSETT, Colin Graham | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | England | British | 152332230001 | |||||||||
| FOX, Gerard Ashley | Amministratore | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 179100520001 | |||||||||
| KEMP, Andrew John | Amministratore | 125 London Wall EC2Y 5AS London 4th Floor United Kingdom | England | British | 222042280001 | |||||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Segretario | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||||||
| HATCHER, Michael Roger | Segretario | Hunyani Ardleigh Road Little Bromley CO11 2QA Manningtree Essex | British | 6759000002 | ||||||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Segretario | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 178916390001 | |||||||||||
| MASLEN, Frederick Charles Archibald | Segretario | 69 Hayes Hill Hayes BR2 7HN Bromley Kent | British | 3770350001 | ||||||||||
| SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs. | Segretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Irish | 45487120004 | ||||||||||
| STAFFORD, Paul Andrew | Segretario | 85 Roman Road IG1 2NZ Ilford Essex | British | 48252270001 | ||||||||||
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| BASING, Anthony Mark | Amministratore | 36 Selwyn Crescent AL10 9NN Hatfield Hertfordshire | British | 99221710001 | ||||||||||
| COOKE, Timothy John | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | 120834610001 | |||||||||
| CUMMING, Andrew John | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||||||
| CUMMING, Andrew John | Amministratore | 305 Mountjoy House Barbican EC2Y 8BP London | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||||||
| DAVIES, John Anthony | Amministratore | Westmead Stables Weedon HP22 4NN Aylesbury Buckinghamshire | British | 32423210001 | ||||||||||
| DAVIES, John Thomas | Amministratore | 2 Hearn Close Tylers Green HP10 8JT Penn Buckinghamshire | British | 2501430001 | ||||||||||
| FOAD, Allan Robert | Amministratore | 19 Dukes Orchard DA5 2DU Bexley Kent | British | 40761160001 | ||||||||||
| FULLELOVE, William Roy | Amministratore | 10 Ennismore Avenue GU1 1SP Guildford Surrey | British | 46128130001 | ||||||||||
| GLEDHILL, Simon Christopher | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 152766650002 | |||||||||
| GRANT, Mark Andrew | Amministratore | Silverdale Avenue KT12 1EL Walton-On-Thames 177 Surrey | United Kingdom | British | 236442470001 | |||||||||
| GREEN, Michael Jonathan | Amministratore | 109 Hampstead Way NW11 7LR London | England | British | 141461000001 | |||||||||
| HARRISON, David Henry Arnold | Amministratore | Woodcote Lodge West Horsley KT24 6ET Leatherhead Surrey | Uk | British | 8949580001 | |||||||||
| HERBERT, Jon Mark | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 203539400001 | |||||||||
| HIGGINS, Peter | Amministratore | 2 Grange Close RH1 4LW Bletchingley Surrey | England | British | 107984310001 | |||||||||
| ISAACS, Robin Alexander | Amministratore | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 115548350001 | |||||||||
| JOSEPH, Michael William | Amministratore | The Hermitage St Leonards HP23 6NW Tring Hertfordshire | England | British | 44954410002 | |||||||||
| KING, Roger Steuart | Amministratore | 9 Kingfisher House No 6 Melbury Road W14 8LN London | United States Citizen | 79713690002 | ||||||||||
| MILES, Peter Bernard | Amministratore | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | 41327480001 | ||||||||||
| MILES, Peter Bernard | Amministratore | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | 41327480001 | ||||||||||
| MOORE, Alan Edward | Amministratore | Flat 2, 20 Wigmore Street W1U 2RQ London | British | 71480200001 | ||||||||||
| PELLY, Richard Fowler | Amministratore | 126 Dora Road Wimbledon SW19 7HJ London | England | British | 99868440002 | |||||||||
| PRITCHARD, David Peter | Amministratore | 17 Thorney Crescent SW11 3TT London | England | British | 57244610001 | |||||||||
| RIDING, Frederick Michael Peter | Amministratore | York House Clifton Down Road BS8 4AG Clifton Bristol | British | 76317830002 | ||||||||||
| SEGGINS, Roger Russell | Amministratore | Marronwood 4 Kelvedon Avenue KT12 5ED Walton On Thames Surrey | British | 46846030003 | ||||||||||
| TATE, George Truett | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 | England | American | 99804980001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Bank Leasing Limited | 06 apr 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed of general assignment | Creato il 01 dic 2003 Consegnato il 05 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company; carolita shipping limited; allco finance (UK) limited; aus shipping LTD; allocean limited; or leif hoegh & co asa to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the right, title and interest, present and future, in, to and under a deed of general assignment dated 20 march 2000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of general assignment between the company, allco finance limited (the "general partner"), allco finance (UK) limited (the "sponsor") and carolita shipping limited (the "owner") in favour of lloyds tsb bank PLC in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and certain other beneficiaries (the "security trustee") | Creato il 20 mar 2000 Consegnato il 03 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys, liabilities and obligations due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with any documents from time to time designated as "transaction documents" by each of the general partner, the investor, the bank guarantor and uih | |
Brevi particolari Right title and interest under a deed of general assignment, a time charter, a guarantee dated 20 march 2000, the benefit of the insurances in respect of the said vessel and any compensation. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security over shares agreement between lloyds bank PLC (as secured party) allco finance limited and the hual carolita limited partnership (together as chargors) | Creato il 04 set 1998 Consegnato il 22 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from allco finance (UK) limited (as obligor) to the chargees under the terms of the agreement and counter-indemnity of even date | |
Brevi particolari 1 (one) ordinary share in the share capital of carolita shipping limited issued and held by to the order to or on behalf of the chargor at any time together with all dividends interest and other monies arising therefrom under paragraph 4.1.1 of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of general assignment and covenant between the company (as investor), carolita shipping limited (as owner), allco finance limited (as general partner) allco finance (UK) limited (as sponsor) and lloyds bank PLC (as assignee) | Creato il 04 set 1998 Consegnato il 22 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a "security party") to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the deed) | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to a). The insurances b). Any requisition compensation c). All sums of money on or from the date of creation of the charge standing to the credit of an account and all related rights thereto and thereof d). The charterparty, the construction supervision agreement, the uih guarantee of charter and secondary put option and all claims rights and remedies of that assignor arising therefrom (inc. All damages and compensation payable) e). The novated shipbuilding contract and the novation agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0