MANOR NATIONAL LIMITED
Panoramica
Nome della società | MANOR NATIONAL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01371549 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MANOR NATIONAL LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MANOR NATIONAL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Avis Budget House Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire England England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MANOR NATIONAL LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MANOR NATIONAL GROUP MOTORS PUBLIC LIMITED COMPANY | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
GYNGELL LIMITED | 01 giu 1978 | 01 giu 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MANOR NATIONAL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per MANOR NATIONAL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 13 set 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Edward Rollason il 26 mar 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Inderpal Lall come segretario in data 20 lug 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gail Marion Jones come segretario in data 20 lug 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 7 Welbeck Street London W1G 9YE a Avis Budget House Park Road Bracknell, Berkshire England RG12 2EW in data 10 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Broughton Secretaries Limited come segretario in data 07 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Edward Rollason come amministratore in data 30 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Joanna Elizabeth Spiers come amministratore in data 30 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Paul Leslie Ford come amministratore in data 30 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jason Christopher Godsell Turner come amministratore in data 30 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MANOR NATIONAL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALL, Inderpal | Segretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 248830120001 | |||||||||||
FORD, Paul Leslie | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 197045450001 | ||||||||
ROLLASON, Paul Edward | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 168157490002 | ||||||||
JONES, Gail Marion | Segretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 177025080001 | |||||||||||
NICHOLSON, Judith Ann | Segretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks England | British | 27201530002 | ||||||||||
BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
BELL, Nina Anne | Amministratore | 11 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | England | British | Accountant | 99807710003 | ||||||||
CATHCART, William Alun | Amministratore | Robin Rag The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | British | Company Director | 9490580007 | |||||||||
COATES, Richard John | Amministratore | 7 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Bucks | British | Vice President | 81363010001 | |||||||||
COATES, Richard John | Amministratore | 7 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Bucks | British | Vice President | 81363010001 | |||||||||
COWAN, Christopher Ian | Amministratore | Ballards Ballards Lane RH8 0SN Limpsfield Surrey | British | Group Finance Director | 54679190001 | |||||||||
FILLINGHAM, Stuart Barry David | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | Accountant | 99807720001 | ||||||||
FORD, Paul Leslie | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 45288050004 | ||||||||
GATES, Edwin Peter | Amministratore | Westcott 5 Millhedge Close KT11 3BE Cobham Surrey | United Kingdom | British | Vice President-Treasury | 38944950001 | ||||||||
HANNA, Kenneth George | Amministratore | 5 Onslow Drive Ascot Mansions SL5 7UL North Ascot Berkshire | British | Company Director | 78515410001 | |||||||||
MALONEY, David Ossian | Amministratore | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 69071800002 | ||||||||
MCCAFFERTY, Mark | Amministratore | 39 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive | 61788610002 | ||||||||
SACHDEVA, Rajiv | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 169861260001 | ||||||||
SMITH, Martyn Robert | Amministratore | 61 Esmond Road W4 1JE London | England | British | Accountant | 100650660001 | ||||||||
SPIERS, Joanna Elizabeth | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 178651670001 | ||||||||
TURNER, Jason Christopher Godsell | Amministratore | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 135757770001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MANOR NATIONAL LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avis Europe Holdings Ltd | 01 giu 2016 | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MANOR NATIONAL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Creato il 11 ago 1992 Consegnato il 18 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries or to any of the beneficiaries pursuant to any of the facility documents (as defined therein) and under the terms of the charge | |
Brevi particolari All estates rights and other interests in f/h property and l/h property a)having a term of more than 25 years unexpired at the date of the acquistion (s ee form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 07 ago 1992 Consegnato il 21 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari See form 395 ref M102. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of debenture | Creato il 03 ago 1990 Consegnato il 15 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany to the chargee as security trustee for the beneficiaries or to any of the beneficiaries pursuant to any of the facility documents or any of the consortium documents as defined in this deed | |
Brevi particolari (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0