VERTU MOTORS CAR LIMITED

VERTU MOTORS CAR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVERTU MOTORS CAR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01371933
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vertu House Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Tyne & Wear
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOTOR NATION CAR HYPERMARKETS LIMITED26 lug 200426 lug 2004
    NATIONAL ALLPARTS LIMITED29 nov 199529 nov 1995
    LLOYDS GARAGE LEASING LIMITED05 giu 197805 giu 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Thomas Forrester il 10 ott 2022

    2 pagineCH01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    legacy

    148 paginePARENT_ACC

    legacy

    4 pagineGUARANTEE1

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed motor nation car hypermarkets LIMITED\certificate issued on 21/03/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name21 mar 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 18 mar 2022

    RES15

    legacy

    4 pagineGUARANTEE1

    legacy

    144 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    146 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    133 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Nicola Jane Carrington Loose come segretario in data 01 mar 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Karen Anderson come segretario in data 01 mar 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael Sherwin come amministratore in data 01 mar 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOOSE, Nicola Jane Carrington
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    Segretario
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    256016130001
    ANDERSON, Karen
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish118122030002
    CRANE, David Paul
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish118813990002
    FORRESTER, Robert Thomas
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish76716700004
    ANDERSON, Karen
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Segretario
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    British149427690001
    LLOYD, Timothy Frederick John
    Lower Oulton House Norbury
    ST20 0PG Stafford
    Staffordshire
    Segretario
    Lower Oulton House Norbury
    ST20 0PG Stafford
    Staffordshire
    British19667690001
    SMILEY, Patrick Joseph
    4 Ravenswood
    Augustus Road
    B15 3LN Birmingham
    Segretario
    4 Ravenswood
    Augustus Road
    B15 3LN Birmingham
    British31109120002
    SMITH, Dennis James
    Grayrigg Radford Rise
    ST17 4PS Stafford
    Staffordshire
    Segretario
    Grayrigg Radford Rise
    ST17 4PS Stafford
    Staffordshire
    British19667670001
    BSG SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    Segretario
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    109290001
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp Time Central
    Tyne And Wear
    Segretario
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp Time Central
    Tyne And Wear
    101749170003
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish89317200001
    FERRY, Steve
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish149057670001
    FOORD, Brian
    White Gables Francis Green Lane
    Penkridge
    ST19 5HE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    White Gables Francis Green Lane
    Penkridge
    ST19 5HE Stafford
    Staffordshire
    British19667680001
    HARRISON, Ian
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish149058230001
    KENT, Colin
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Kingsway North
    Team Valley
    NE11 0JH Gateshead
    Vertu House
    Tyne And Wear
    UkBritish120333580001
    KEWITT, Kenneth Arthur
    21 Parsons Drive
    Richmond Park Gnosall
    ST20 0QS Stafford
    Amministratore
    21 Parsons Drive
    Richmond Park Gnosall
    ST20 0QS Stafford
    British33934820001
    LLOYD, Timothy Frederick John
    Lower Oulton House Norbury
    ST20 0PG Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Lower Oulton House Norbury
    ST20 0PG Stafford
    Staffordshire
    British19667690001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    British34653220001
    SCOTT, Norman
    7 Cherry Tree Crescent
    Great Bridgeford
    ST18 9TN Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    7 Cherry Tree Crescent
    Great Bridgeford
    ST18 9TN Stafford
    Staffordshire
    British28744160001
    SHERWIN, Michael
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    EnglandBritish65202240005
    SMILEY, Patrick Joseph
    4 Ravenswood
    Augustus Road
    B15 3LN Birmingham
    Amministratore
    4 Ravenswood
    Augustus Road
    B15 3LN Birmingham
    United KingdomBritish31109120002
    SMITH, Dennis James
    Grayrigg Radford Rise
    ST17 4PS Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Grayrigg Radford Rise
    ST17 4PS Stafford
    Staffordshire
    British19667670001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    British41591930001
    TUSTAIN, John Bernard
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish128982570002
    WHEELWRIGHT, Derek Arthur
    3 Carnwath Road
    B73 6JP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 Carnwath Road
    B73 6JP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British15325110001
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    British15080230001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VERTU MOTORS CAR LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    England
    06 apr 2016
    Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Vertu House
    Tyne & Wear
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England & Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05984855
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VERTU MOTORS CAR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 16 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to clause 7.3 of an agreement dated 18 march 1997 (as therein defined) or this composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bsg International PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 14 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 11 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All used motor vehicles which are from time to time during the continuance of this security in the possession of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 11 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 09 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each security company (as defined) to the secured parties (or any of them) (as defined) under the mezzanine credit agreement,the lender documents (or any of them) and under this deed on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Legal & General Ventures Limitedas Security Trustee for the Lenders and the Lenders
    Transazioni
    • 09 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0