VERTU MOTORS CAR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | VERTU MOTORS CAR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01371933 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VERTU MOTORS CAR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Vertu House Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Tyne & Wear |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MOTOR NATION CAR HYPERMARKETS LIMITED | 26 lug 2004 | 26 lug 2004 |
| NATIONAL ALLPARTS LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 |
| LLOYDS GARAGE LEASING LIMITED | 05 giu 1978 | 05 giu 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Thomas Forrester il 10 ott 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
legacy | 148 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 4 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed motor nation car hypermarkets LIMITED\certificate issued on 21/03/22 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 144 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 146 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 133 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Nicola Jane Carrington Loose come segretario in data 01 mar 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Anderson come segretario in data 01 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Sherwin come amministratore in data 01 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOSE, Nicola Jane Carrington | Segretario | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear | 256016130001 | |||||||
| ANDERSON, Karen | Amministratore | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 118122030002 | |||||
| CRANE, David Paul | Amministratore | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 118813990002 | |||||
| FORRESTER, Robert Thomas | Amministratore | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 76716700004 | |||||
| ANDERSON, Karen | Segretario | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear United Kingdom | British | 149427690001 | ||||||
| LLOYD, Timothy Frederick John | Segretario | Lower Oulton House Norbury ST20 0PG Stafford Staffordshire | British | 19667690001 | ||||||
| SMILEY, Patrick Joseph | Segretario | 4 Ravenswood Augustus Road B15 3LN Birmingham | British | 31109120002 | ||||||
| SMITH, Dennis James | Segretario | Grayrigg Radford Rise ST17 4PS Stafford Staffordshire | British | 19667670001 | ||||||
| BSG SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Seton House Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DE Warwick | 109290001 | |||||||
| HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham West Midlands | 73037780002 | |||||||
| MUCKLE SECRETARY LIMITED | Segretario | 32 Gallowgate NE1 4BF Newcastle Upon Tyne C/O Muckle Llp Time Central Tyne And Wear | 101749170003 | |||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| DAWSON, Anthony David | Amministratore | Flat 21 Hillbrow Richmond Hill TW10 6BH Richmond Surrey | United Kingdom | British | 89317200001 | |||||
| FERRY, Steve | Amministratore | Kingsway North Team Valley NE11 0JH Gateshead Vertu House Tyne And Wear | United Kingdom | British | 149057670001 | |||||
| FOORD, Brian | Amministratore | White Gables Francis Green Lane Penkridge ST19 5HE Stafford Staffordshire | British | 19667680001 | ||||||
| HARRISON, Ian | Amministratore | Kingsway North Team Valley NE11 0JH Gateshead Vertu House Tyne And Wear | United Kingdom | British | 149058230001 | |||||
| KENT, Colin | Amministratore | Kingsway North Team Valley NE11 0JH Gateshead Vertu House Tyne And Wear | Uk | British | 120333580001 | |||||
| KEWITT, Kenneth Arthur | Amministratore | 21 Parsons Drive Richmond Park Gnosall ST20 0QS Stafford | British | 33934820001 | ||||||
| LLOYD, Timothy Frederick John | Amministratore | Lower Oulton House Norbury ST20 0PG Stafford Staffordshire | British | 19667690001 | ||||||
| MARTON, Richard Egerton Christopher | Amministratore | Capernwray 6 Kier Park SL5 7DS Ascot Berkshire | British | 34653220001 | ||||||
| SCOTT, Norman | Amministratore | 7 Cherry Tree Crescent Great Bridgeford ST18 9TN Stafford Staffordshire | British | 28744160001 | ||||||
| SHERWIN, Michael | Amministratore | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear United Kingdom | England | British | 65202240005 | |||||
| SMILEY, Patrick Joseph | Amministratore | 4 Ravenswood Augustus Road B15 3LN Birmingham | United Kingdom | British | 31109120002 | |||||
| SMITH, Dennis James | Amministratore | Grayrigg Radford Rise ST17 4PS Stafford Staffordshire | British | 19667670001 | ||||||
| TURNBULL, Peter | Amministratore | Much Binding Marsh HP17 8SS Aylesbury Buckinghamshire | British | 41591930001 | ||||||
| TUSTAIN, John Bernard | Amministratore | Clattercut Lane Rushock WR9 0NN Droitwich The Old Oak Barn Worcestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 128982570002 | |||||
| WHEELWRIGHT, Derek Arthur | Amministratore | 3 Carnwath Road B73 6JP Sutton Coldfield West Midlands | British | 15325110001 | ||||||
| WILLIAMS, Paul Raymond | Amministratore | Summerfields House Stoke Pound Lane Stoke Prior B60 4LE Bromsgrove Worcestershire | British | 15080230001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VERTU MOTORS CAR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertu Motors Plc | 06 apr 2016 | Fifth Avenue Business Park Team Valley NE11 0XA Gateshead Vertu House Tyne & Wear England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
VERTU MOTORS CAR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 27 mar 2007 Consegnato il 04 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 04 apr 1997 Consegnato il 16 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to clause 7.3 of an agreement dated 18 march 1997 (as therein defined) or this composite guarantee and debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 apr 1997 Consegnato il 14 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on vehicle stocks | Creato il 04 apr 1997 Consegnato il 11 apr 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All used motor vehicles which are from time to time during the continuance of this security in the possession of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 apr 1997 Consegnato il 11 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Group debenture | Creato il 04 apr 1997 Consegnato il 09 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each security company (as defined) to the secured parties (or any of them) (as defined) under the mezzanine credit agreement,the lender documents (or any of them) and under this deed on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0