CHG DESIGN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHG DESIGN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01372655
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHG DESIGN LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CHG DESIGN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHG DESIGN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPLASHDOWN LIMITED06 ott 199506 ott 1995
    LEWIN & WARNER LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    RAWPRENT LIMITED09 giu 197809 giu 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHG DESIGN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CHG DESIGN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2016

    Stato del capitale al 16 feb 2016

    • Capitale: GBP 1,509,940
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Flowers il 13 mar 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2015

    Stato del capitale al 11 feb 2015

    • Capitale: GBP 1,509,940
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013

    8 pagineAA

    Nomina di Sarah Louise Ellard come amministratore in data 24 lug 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael James Flowers come amministratore in data 24 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Harry Papworth come amministratore in data 24 lug 2014

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Cherming House 1500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AF* in data 01 lug 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Steven John Bowers come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CHG DESIGN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    HOTHAM, Edward Durand
    Ashcroft Furlong
    Chadlington
    OX7 3NY Chipping Norton
    Oxon
    Segretario
    Ashcroft Furlong
    Chadlington
    OX7 3NY Chipping Norton
    Oxon
    British29531580001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Segretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    ARMSTRONG, John Arthur
    6 Firtree Lane
    Swinford
    LE17 6BH Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    6 Firtree Lane
    Swinford
    LE17 6BH Lutterworth
    Leicestershire
    British11951100001
    ATTWOOD, David John
    27 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    27 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    British50715130001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    EATON, John George
    66 Glemsford Road
    IP14 2PW Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    66 Glemsford Road
    IP14 2PW Stowmarket
    Suffolk
    British24249280001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritish4471420003
    FERRIS, David
    31 Coniston Road
    SN14 0PX Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    31 Coniston Road
    SN14 0PX Chippenham
    Wiltshire
    British50715150001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Amministratore
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    HOTHAM, Edward Durand
    Ashcroft Furlong
    Chadlington
    OX7 3NY Chipping Norton
    Oxon
    Amministratore
    Ashcroft Furlong
    Chadlington
    OX7 3NY Chipping Norton
    Oxon
    British29531580001
    KENNEDY, Ian Gordon
    53 Kingsley Road
    IG10 3TU Loughton
    Essex
    Amministratore
    53 Kingsley Road
    IG10 3TU Loughton
    Essex
    British29531590001
    LEVERATT, Bryan Creagh
    Hunters Lodge Hall Road
    Bedingfield Eye
    IP23 7QE Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Hunters Lodge Hall Road
    Bedingfield Eye
    IP23 7QE Ipswich
    Suffolk
    British24249290001
    LEWIN, David Charles Pearman
    Mulberry
    West Quay
    CM0 8AS Burnham On Crouch
    Essex
    Amministratore
    Mulberry
    West Quay
    CM0 8AS Burnham On Crouch
    Essex
    United KingdomBritish150605700001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHG DESIGN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione86662
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CHG DESIGN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 30 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Noteholders and the Purchasers)
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 14 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over book debts
    Creato il 23 gen 1996
    Consegnato il 13 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book/other debts from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 1994
    Consegnato il 05 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 01 nov 1993
    Consegnato il 16 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 03 dic 1991
    Consegnato il 13 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s)of the company with the bank designated barclays bank PLC re: lewin & warner limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or philip courtenay thomas warner to the chargee under the terms of the facility agreement dated 29TH august 1991 and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all the freehold and leasehold property and all the goodwill and uncalled capital,all bookdebts ans other debts, undertaking, property and assets (see doc ref M534C for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Private Bank & Trust Company Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 1990
    Consegnato il 21 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0