CHG DESIGN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHG DESIGN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01372655 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHG DESIGN LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CHG DESIGN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHG DESIGN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SPLASHDOWN LIMITED | 06 ott 1995 | 06 ott 1995 |
| LEWIN & WARNER LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| RAWPRENT LIMITED | 09 giu 1978 | 09 giu 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHG DESIGN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHG DESIGN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Flowers il 13 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Sarah Louise Ellard come amministratore in data 24 lug 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael James Flowers come amministratore in data 24 lug 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Harry Papworth come amministratore in data 24 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Cherming House 1500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AF* in data 01 lug 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Steven John Bowers come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHG DESIGN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Segretario | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| HOTHAM, Edward Durand | Segretario | Ashcroft Furlong Chadlington OX7 3NY Chipping Norton Oxon | British | 29531580001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Segretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
| ARMSTRONG, John Arthur | Amministratore | 6 Firtree Lane Swinford LE17 6BH Lutterworth Leicestershire | British | 11951100001 | ||||||
| ATTWOOD, David John | Amministratore | 27 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | 50715130001 | ||||||
| BILLINGTON, Philip Gordon | Amministratore | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | 18247670001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| EATON, John George | Amministratore | 66 Glemsford Road IP14 2PW Stowmarket Suffolk | British | 24249280001 | ||||||
| EVANS, David Roger | Amministratore | Yoxhall Lodge 10 Worsley Road PO5 3DY Southsea Hampshire | England | British | 4471420003 | |||||
| FERRIS, David | Amministratore | 31 Coniston Road SN14 0PX Chippenham Wiltshire | British | 50715150001 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| GIBBS, Raymond John | Amministratore | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | 85421380001 | ||||||
| HOTHAM, Edward Durand | Amministratore | Ashcroft Furlong Chadlington OX7 3NY Chipping Norton Oxon | British | 29531580001 | ||||||
| KENNEDY, Ian Gordon | Amministratore | 53 Kingsley Road IG10 3TU Loughton Essex | British | 29531590001 | ||||||
| LEVERATT, Bryan Creagh | Amministratore | Hunters Lodge Hall Road Bedingfield Eye IP23 7QE Ipswich Suffolk | British | 24249290001 | ||||||
| LEWIN, David Charles Pearman | Amministratore | Mulberry West Quay CM0 8AS Burnham On Crouch Essex | United Kingdom | British | 150605700001 | |||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Amministratore | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHG DESIGN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemring Group Plc | 30 giu 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CHG DESIGN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 19 nov 2009 Consegnato il 30 nov 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 12 nov 2007 Consegnato il 20 nov 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 05 feb 2001 Consegnato il 14 feb 2001 | In corso | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over book debts | Creato il 23 gen 1996 Consegnato il 13 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book/other debts from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 nov 1994 Consegnato il 05 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 01 nov 1993 Consegnato il 16 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 03 dic 1991 Consegnato il 13 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s)of the company with the bank designated barclays bank PLC re: lewin & warner limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 ott 1991 Consegnato il 07 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany and/or philip courtenay thomas warner to the chargee under the terms of the facility agreement dated 29TH august 1991 and this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all the freehold and leasehold property and all the goodwill and uncalled capital,all bookdebts ans other debts, undertaking, property and assets (see doc ref M534C for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 feb 1990 Consegnato il 21 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0