UNITRANS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNITRANS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01372780
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNITRANS LIMITED?

    • Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova UNITRANS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhousecoopers Llp Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNITRANS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONCORDE LOGISTICS LIMITED26 ago 199426 ago 1994
    AERLOAD (WAREHOUSING) LIMITED22 gen 199322 gen 1993
    ELECTRONIC TRANSPORT SERVICES LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    KELDERLING LIMITED12 giu 197812 giu 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNITRANS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per UNITRANS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    28 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    87 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    72 pagineAM10

    Cessazione della carica di Mark Xavier Jackson come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gary David Mcdonald come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Henry Robins come segretario in data 16 lug 2021

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Darren Brian Hall come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    81 pagineAM10

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    65 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    10 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor the Globe Centre, 1 st James Square Accrington Lancashire BB5 0RE England a Pricewaterhousecoopers Llp Level 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds England LS1 4DL in data 04 nov 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    59 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Festival House Jessop Avenue Cheltenham Gloucestershire GL50 3SH a 3rd Floor the Globe Centre, 1 st James Square Accrington Lancashire BB5 0RE in data 17 apr 2020

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Mark Xavier Jackson come amministratore in data 20 mar 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 set 2018

    34 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 013727800014, creata il 14 nov 2019

    45 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 013727800012 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Darren Brian Hall come amministratore in data 01 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kalwant Singh come amministratore in data 01 ott 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 27 set 2018 al 26 set 2018

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di UNITRANS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHCROFT, Mark
    Northway Lane
    GL20 8GY Tewkesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Northway Lane
    GL20 8GY Tewkesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    United Kingdom
    British125633820001
    FLETCHER, David Neil
    36 Oakbark House
    High Street
    TW8 8LF Brentford
    Middlesex
    Segretario
    36 Oakbark House
    High Street
    TW8 8LF Brentford
    Middlesex
    BritishCompany Director38335130002
    O'HAGAN, Timothy Joseph
    Old Bull House Bridge Road
    KT16 8LA Chertsey
    Surrey
    Segretario
    Old Bull House Bridge Road
    KT16 8LA Chertsey
    Surrey
    British45629560001
    ROBINS, John Henry
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    Segretario
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    156524720001
    CAHILL, Stephen William
    8 Carlisle Close
    HA5 1JN Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    8 Carlisle Close
    HA5 1JN Pinner
    Middlesex
    IrishCompany Director124640760001
    CAMPBELL, Stephen Barry
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector117524210001
    CAPLE, Andrew James
    Meriholm
    Cwm Drive
    CF64 4HL Dinas Powys
    South Glamorgan
    Amministratore
    Meriholm
    Cwm Drive
    CF64 4HL Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritishCompany Director60520870002
    DAVIES, Colin Gwynne
    The Paddocks
    Ramsbury
    SN8 2QF Marlborough
    9
    Wiltshire
    Amministratore
    The Paddocks
    Ramsbury
    SN8 2QF Marlborough
    9
    Wiltshire
    United KingdomBritishOperations Director128646310001
    DEARMAN, Benjamin John
    60 Barnfield Road
    AL5 5TQ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    60 Barnfield Road
    AL5 5TQ Harpenden
    Hertfordshire
    UkBritishCompany Director74257760001
    DIEPERINK, Philip Jean
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director124398320004
    DOWNS, Brian George
    5 Academy Court
    TW16 6AN Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    5 Academy Court
    TW16 6AN Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishCompany Director16432980001
    ELMES, Alan Mark, Mr.
    Wyld Court
    Hawkchurch
    EX13 5TZ Axminster
    Devon
    Amministratore
    Wyld Court
    Hawkchurch
    EX13 5TZ Axminster
    Devon
    EnglandBritishCompany Director125878430001
    ELMES, Alan Mark
    Flat 4 Selhurst Court
    Gordon Road
    GU15 2JQ Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Flat 4 Selhurst Court
    Gordon Road
    GU15 2JQ Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director17539210002
    FLETCHER, David Neil
    36 Oakbark House
    High Street
    TW8 8LF Brentford
    Middlesex
    Amministratore
    36 Oakbark House
    High Street
    TW8 8LF Brentford
    Middlesex
    BritishCompany Director38335130002
    GRAD, Christopher John Nicholas
    The Pavilion Silwood Road
    Sunninghill
    SL5 0PY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    The Pavilion Silwood Road
    Sunninghill
    SL5 0PY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director12441340001
    GRAD, Markus Jack Karl
    49 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    49 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    BritishCompany Director106339100001
    HALL, Darren Brian
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    Amministratore
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    United KingdomBritishSupply Chain And Logistics Dir262915460001
    JACKSON, Mark Xavier
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritishFinance Director268327560001
    JOY, Alan
    Leyland Farm Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Leyland Farm Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director126282250001
    LITTLEY, Steven Belford
    Whitford Road
    Kilmington
    EX13 7NS Axminster
    Hills Farm
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitford Road
    Kilmington
    EX13 7NS Axminster
    Hills Farm
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director93689480003
    MARTIN, Johan Daniel
    Northway Lane
    Ashchurch
    ADIICEFGL20 89U Tewesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    Amministratore
    Northway Lane
    Ashchurch
    ADIICEFGL20 89U Tewesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    United KingdomBritish,South AfricanManaging Director146571530002
    MCDONALD, Gary David
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    Amministratore
    Level 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Pricewaterhousecoopers Llp
    England
    EnglandSouth AfricanChartered Accountant86472350004
    O'HAGAN, Timothy Joseph
    Old Bull House Bridge Road
    KT16 8LA Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Old Bull House Bridge Road
    KT16 8LA Chertsey
    Surrey
    BritishCompany Director45629560001
    SINGH, Kalwant
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    Amministratore
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector Of Logistics202695270001
    STANDER, Christoffel Adriaan
    Northway Lane
    Ashchurch
    GL20 89U Tewesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    Amministratore
    Northway Lane
    Ashchurch
    GL20 89U Tewesbury
    Steinhoff Uk Group
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinance Director146571310001
    SUMMERS, Sean
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    Amministratore
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector168986260001
    SUMMERS, Sean
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector168986260001
    TILLEY, Peter Maxwell
    22 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5EU London
    Amministratore
    22 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5EU London
    BritishDirector38620900001
    WILLIAMS, Kenneth George
    Wyke Cottage
    76 Crescent Road
    TW17 8BP Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    Wyke Cottage
    76 Crescent Road
    TW17 8BP Shepperton
    Middlesex
    BritishDirector80193320002

    Chi sono le persone con controllo significativo di UNITRANS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Unitrans Logistics (Uk) Limited
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Fifth Floor, Festival House
    England
    06 apr 2016
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Fifth Floor, Festival House
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione5523550
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    UNITRANS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 nov 2019
    Consegnato il 27 nov 2019
    In corso
    Breve descrizione
    All of its right, title and interest in the real property and intellectual property as specified and defined in the debenture (the “debenture”), for more details please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Blue Group Cayman, LTD
    Transazioni
    • 27 nov 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 giu 2019
    Consegnato il 04 lug 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Steinhoff UK Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 gen 2018
    Consegnato il 09 gen 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1 winover road, huntingdon. For more details of land, ship, aircraft or intellectual property charged please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2007
    Consegnato il 24 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2002
    Consegnato il 02 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery computers office and other equipment cash at bank and other debts and goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Rbc Trustees (Guernsey) Limited as Trustee of the Peter Tilley Life Interest Settlement
    Transazioni
    • 02 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 apr 2002
    Consegnato il 29 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 16 ago 1994
    Consegnato il 05 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1991
    Consegnato il 15 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 30 mag 1986
    Consegnato il 13 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 giu 1982
    Consegnato il 09 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 2, 8, boeing way, international trading estate, southall, ealing.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 feb 1981
    Consegnato il 25 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 8 boeing way, international trading estate, southall, london borough of ealing.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 1980
    Consegnato il 06 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    UNITRANS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 giu 2020Inizio dell'amministrazione
    04 lug 2022Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Yulia Marshall
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0