RAMFIELD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAMFIELD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01374556
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAMFIELD LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RAMFIELD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PO BOX 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAMFIELD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAMFIELD PLC21 giu 197821 giu 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAMFIELD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per RAMFIELD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 12 mag 2016

    3 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    6 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 dic 2015

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 giu 2015

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 26 nov 2015

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 giu 2015

    3 pagine3.6

    Cessazione della carica di Christopher Pearson come amministratore in data 26 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2014

    Stato del capitale al 19 set 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per The Spring Ram Corporation Limited il 06 feb 2014

    1 pagineCH02

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Dettagli del direttore cambiati per The Spring Ram Corporation Plc il 22 mar 2013

    1 pagineCH02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ago 2013

    Stato del capitale al 23 ago 2013

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Cessazione della carica di David Mackinnon come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Mackinnon come amministratore

    2 pagineTM01

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    23 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Chi sono gli amministratori di RAMFIELD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    MACKINNON, David Stuart
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    Segretario
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    British64869460001
    OLDROYD, Claire Louise
    33a Valley Road
    Thornhill
    WF12 0HY Dewsbury
    West Yorkshire
    Segretario
    33a Valley Road
    Thornhill
    WF12 0HY Dewsbury
    West Yorkshire
    British23531300001
    RAVEN, Mark
    7 Paddock Close
    Drighlington
    BD11 1LD Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    7 Paddock Close
    Drighlington
    BD11 1LD Bradford
    West Yorkshire
    British68758360001
    WEAVER, Paul
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    Segretario
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    British45193280001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BUTTERWORTH, Anthony
    St Julien 3 Church Lane
    Cawthorne
    S75 4DW Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    St Julien 3 Church Lane
    Cawthorne
    S75 4DW Barnsley
    South Yorkshire
    EnglandBritish10217580001
    COLLIER, Andrew
    25 Daisy Road
    HD6 3SY Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Daisy Road
    HD6 3SY Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritish32328370001
    FARR, Ronald
    Greenways 7 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Greenways 7 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    West Yorkshire
    British38053260001
    FLANNERY, Lisa
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish69964220001
    GREENWOOD, Stuart Alan
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    Amministratore
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    EnglandBritish126211960001
    MACKENZIE, Andrew Macgregor
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    Amministratore
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    British38695210001
    MACKINNON, David Stuart
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    EnglandBritish64869460001
    PEARSON, Christopher
    PO BOX 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    PO BOX 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritish174624400001
    PRINCE, Mark Bramley
    Oak Cottage Leas Gardens
    Jackson Bridge
    HD9 1UG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Oak Cottage Leas Gardens
    Jackson Bridge
    HD9 1UG Huddersfield
    West Yorkshire
    WalesWelsh50891570001
    REGAN, Bernard Roger
    8 The Quadrangle
    Chelsea Harbour
    SW10 0UG London
    Amministratore
    8 The Quadrangle
    Chelsea Harbour
    SW10 0UG London
    United KingdomBritish6548970001
    REGAN, Bernard Roger
    8 The Quadrangle
    Chelsea Harbour
    SW10 0UG London
    Amministratore
    8 The Quadrangle
    Chelsea Harbour
    SW10 0UG London
    United KingdomBritish6548970001
    ROONEY, William Thomas
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish18244740001
    SYKES, David Thomas
    The Old Rectory 80 Barnsley Road
    Upper Cumberworth
    HD8 8NN Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Rectory 80 Barnsley Road
    Upper Cumberworth
    HD8 8NN Huddersfield
    West Yorkshire
    British61293790002
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    British36252860002
    TROTTER, Robin Hudson
    Carradale
    Hob Lane
    HX6 4LU Ripponden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Carradale
    Hob Lane
    HX6 4LU Ripponden
    West Yorkshire
    British78730570001
    WEAVER, Paul
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    British45193280001
    WHITE, Philip Charles
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SE Bradford
    Woodlands 21
    West Yorkshire
    Amministratore
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SE Bradford
    Woodlands 21
    West Yorkshire
    EnglandBritish112021740001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    CRS OLD LIMITED
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    572
    BD4 6SE Bradford
    21
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    572
    BD4 6SE Bradford
    21
    West Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1398977
    174629640021

    RAMFIELD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 dic 2012
    Consegnato il 28 dic 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H one holden ing way birstall west yorkshire t/nos WYK423063, WYK423980 and WYK590022, f/h land and buildings at roydsdale way euroway trading estate bradford west yorkshire t/nos WYK214956 and WYK158634 and f/h land and buildings at silverdale road newcastle under lyme staffordshire t/no SF151966 for details of further property charged please refer to form 395 all benefits in respect of all contracts or policies if insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Jacuzzi UK Retirement Benefit Scheme Being Lisa Flannery, Jeffrey Bryanpark, Mark Bramley Prince, Philip Anthony Wild and the Law Debenture Pension Trust Corporation PLC (The Trustees)
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 102 lug 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 226 lug 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 326 lug 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 107 gen 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 223 giu 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 323 giu 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 3
      • Numero di pratica 1
      • Numero di pratica 2
    Supplemental charge to a composite guarantee and mortgage debenture dated 11TH march 1996
    Creato il 20 ago 1996
    Consegnato il 27 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the chargee (as security trustee) and the secured parties (as defined)
    Brevi particolari
    F/H land forming part of holden ing way birstall t/n WYK529583 and f/h land on the north side of owler lane birstall t/n WYK423980.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 11 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at the top of holden ings way birstall t/no.WYK423063. F/h property situated at huddersfield road darton barnsley t/nos.SYK305511 and SYK327807. F/h property situated at normanby road foxhills industrial estate scunthorpe t/no.HS133722. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 1993
    Consegnato il 22 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 08 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,300,000.
    Brevi particolari
    Land adjoacent to gelderd road, bristol.west yorkshire. Title nos: wyk 387833 and wyk 423063.
    Persone aventi diritto
    • Ikea Properties Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1987
    Consegnato il 18 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H property situate in gelderd road birstall batley west yorkshire f/h land k/a paradise farm gelderd rd birstall batley t/n wyk 196239.
    Persone aventi diritto
    • The Council of the Borough of Kirklees
    Transazioni
    • 18 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 lug 1986
    Consegnato il 18 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at wharfedale road, eurowayindustrial estate, bradford, west yorkshire, title nos wyk 309056 & wyk 317452.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 13 apr 1984
    Consegnato il 18 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £480,000
    Brevi particolari
    All that plot of land at roydsdale way euroway industrial estate, bradford west yorkshire. Title nos. Wyk 158634 and WYK214956.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 18 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 gen 1984
    Consegnato il 15 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £480,000
    Brevi particolari
    Land off wharfedale rd,euroway ind.est.bradford W.yorks part of t/nwyk 193021.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 15 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 lug 1983
    Consegnato il 29 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land off watson mill lane sowerby bridgew. Yorks. Titel no wyk 164430 and or theproceeds sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1983
    Consegnato il 30 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land near scar head road scar head soverby bridge west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof part of title no. Wyk 245449.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1982
    Consegnato il 07 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate at watson mill lane, sowerby bridge, west yorkshire containing approximately 8.5 acres and being ordnance surrey field numbers, 11,12,13,20 & 21.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1982
    Consegnato il 07 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of sear headroad sowerby bridge, west yorkshire title wyk 218642 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1982
    Consegnato il 05 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land & buildings on the east side f watsonhil lane, sawerby bridge, westyorkshire. Title no. Wyk 164001.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1981
    Consegnato il 04 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate at or near watson mill lane, sowerby bridge halifax west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 set 1981
    Consegnato il 21 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land situate at or near watson mill lane sowerby bridge halifax west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 feb 1981
    Consegnato il 20 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and otherdebts floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. (Excluding those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    RAMFIELD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Keith Roe
    Eddisons Llp Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    Eddisons Llp Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons Llp Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    Eddisons Llp Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Swiers
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    Ricevitore/gestore
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    Michael Daniel Worsley Hardy
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    West Yorkshire
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Swiers
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    Ricevitore/gestore
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    Michael Daniel Worsley Hardy
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    25 Wellington Street
    LS1 4WG Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0