EMAP MEDIA LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EMAP MEDIA LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01376056 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EMAP MEDIA LIMITED?
- (7499) /
- (9999) /
Dove si trova EMAP MEDIA LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Greater London House Hampstead Road NW1 7EJ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EMAP MEDIA LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EMAP VISION LIMITED | 23 feb 1989 | 23 feb 1989 |
| XRP (NO.1) LIMITED | 11 apr 1986 | 11 apr 1986 |
| COACHMART LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
| REDRAVEN LIMITED | 29 giu 1978 | 29 giu 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EMAP MEDIA LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per EMAP MEDIA LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di David Gilbertson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Emily Henrietta Gestetner come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Tracey Gray come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 30 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 30 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tracey Marie Gray il 14 mag 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Shanny Looi il 01 mar 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Stuart Gilbertson il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tracey Marie Gray il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Frances Hay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Helen Frances Hay come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 225 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 11 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EMAP MEDIA LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOI, Shanny | Segretario | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 134332760002 | |||||
| ELSDON, Kate | Segretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Segretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HAY, Helen Frances | Segretario | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146425970001 | |||||||
| HENSON, Mark Richard | Segretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Segretario | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Segretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| ADAMS, Josephine Margaret, Ba | Amministratore | 49 Queen Margarets Grove N1 4PZ London | British | 65137590002 | ||||||
| ARNOLD, William John Felix | Amministratore | 4 Grimwood Road TW1 1BX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 43128580001 | |||||
| BAKER, Jonathan Mark | Amministratore | 129a Southgate Road N1 3JZ London | British | 63370080001 | ||||||
| BROOKS, Timothy Stephen | Amministratore | 75 Ronalds Road Highbury N5 1XB London | British | 72643520001 | ||||||
| BROWN, Philip | Amministratore | Greydene Station Road, Woldingham CR3 7DD Caterham Surrey | United Kingdom | British | 70412460002 | |||||
| BUCKLEY, Steven Robert | Amministratore | 47 Osbaldeston Road N16 7DL London | British | 29883940002 | ||||||
| CARTER, Derek Raymond Anthony | Amministratore | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 29959930002 | |||||
| ELLIOT, Richard Emmerson | Amministratore | Orchard House 2 Richardson Close, Mill Drove PE10 9YN Bourne Lincolnshire | United Kingdom | British | 40591070005 | |||||
| FLYNN, Anne Marie | Amministratore | 42 Streatham Hill (Raised Ground Floor Flat) SW2 4RA London | England | British | 60758860001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| GOUGH, Malcolm Howard | Amministratore | South Lodge Fineshade Abbey Fineshade NN17 3BA Corby Northamptonshire | United Kingdom | British | 124396590001 | |||||
| GRAY, Tracey Marie | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 130960400002 | |||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Amministratore | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | 99547790001 | |||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Amministratore | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | 99547790001 | |||||
| HARRIS, Anthony Charles | Amministratore | 58 Belsize Park NW3 4EH London | British | 67943140004 | ||||||
| JONES, Michael James | Amministratore | 43 Charteris Road NW6 7EY London | British | 65883830001 | ||||||
| LAWS, Malcolm | Amministratore | 64 Porchester Terrace W2 3TP London | British | 64109690001 | ||||||
| MCALEENAN, Patrick David | Amministratore | 78 Hazlewell Road Putney SW15 6UR London | England | British | 14226510001 | |||||
| MIDDELBOE, Simon Richard | Amministratore | Forge Cottage Tumblefield Road TN15 7PR Stansted Kent | British | 106823450001 | ||||||
| MORRISON, Colin | Amministratore | 41 The Downs Wimbledon SW20 8HG London | England | British | 199593010001 | |||||
| O'NEILL, Shane | Amministratore | 44 Homefield Road Chiswick W4 2LW London | British | 54019770001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Edmund Gerard | Amministratore | 44 St Georges Avenue N7 0HD London | British | 40019720002 | ||||||
| PUSEY, Catharine Anne Veronica | Amministratore | 2 Monks Close Redbourn AL3 7LY St Albans Herts | England | British | 127469780001 | |||||
| SEGAL, David | Amministratore | 3 Goodwyns Vale N10 2HA London | British | 79686640001 | ||||||
| STRINGER, Thomas Howard | Amministratore | 29 Chace Avenue EN6 5LY Potters Bar Hertfordshire | British | 55667030001 |
EMAP MEDIA LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 28 giu 1983 Consegnato il 07 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0