SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED

SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01377528
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Shepherds Building Central
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAVILION INTERNATIONAL LIMITED18 ott 199318 ott 1993
    VATV LIMITED17 ott 198817 ott 1988
    DUMBARTON FILMS LIMITED19 ott 198419 ott 1984
    VIDEO ARTS TELEVISION LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    CURLGATE LIMITED07 lug 197807 lug 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Stato del capitale al 23 gen 2023

    • Capitale: GBP 12,001
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 gen 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Marie Lucile Schweitzer come amministratore in data 09 dic 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Shepherds Building Central Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way London W14 0EE United Kingdom a Shepherds Building Central Charecroft Way London W14 0EE in data 03 ago 2022

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    15 pagineAA

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Marie Schweitzer come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Anthony John Richards come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KEPPLER, Bronagh Elizabeth Ann
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Segretario
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    172421360001
    PAYNE, Catherine Patricia
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandAustralian205324840001
    RICHARDS, Anthony John
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandBritish269661310001
    BARRON, Maureen Patricia
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    Segretario
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    Australian71849590001
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Segretario
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    British39895440002
    IRLAM, Felicity Mary
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    Segretario
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    British42627330001
    MEACOCK, Catherine Anne
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    Segretario
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    British46175710002
    TATE, Maxine
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    Segretario
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    British60430270003
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    United Kingdom
    Segretario
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    United Kingdom
    38636470004
    ASTAIRE, Mark David
    28 Cressy Road
    NW3 2LY London
    Amministratore
    28 Cressy Road
    NW3 2LY London
    British14529980002
    BALNAVES, Neil Richard
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Amministratore
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Australian53758580001
    BALNAVES, Neil Richard
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Amministratore
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Australian53758580001
    BIRKS, Clare
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    Amministratore
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    United KingdomBritish60648500001
    BIRKS, Clare
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    Amministratore
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    United KingdomBritish60648500001
    CLARK, Peter Antony
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    Amministratore
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    United KingdomBritish60713200001
    DOWNING, Terry William
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritish109287950001
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish39895440002
    HARRIS, Ann Jane
    5 Warren Road
    UB10 8AA Ickenham
    Middlesex
    Amministratore
    5 Warren Road
    UB10 8AA Ickenham
    Middlesex
    British41306650001
    LIGHTING, Jane Elizabeth Stuart
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    Amministratore
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    United KingdomBritish49969850002
    LYONS, Frank
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    Amministratore
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    Irish71588050002
    MEERING, Andrew David
    72 Glasslyn Road
    N8 London
    Amministratore
    72 Glasslyn Road
    N8 London
    British44828100003
    MORETON, Christopher Quinton
    38 Lansdowne Road
    TN1 2NL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    38 Lansdowne Road
    TN1 2NL Tunbridge Wells
    Kent
    British52075080001
    MORRIS, Roland Anthony
    19 Kings Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UX London
    Sw10
    Amministratore
    19 Kings Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UX London
    Sw10
    British37407550002
    NEWMAN, Douglas Geoffrey Forsyth
    22 Merrivale Road
    Pymble
    New South Wales
    2073
    Australia
    Amministratore
    22 Merrivale Road
    Pymble
    New South Wales
    2073
    Australia
    Australian62712190001
    NEWMAN, Douglas Geoffrey Forsyth
    22 Merrivale Road
    Pymble
    New South Wales
    2073
    Australia
    Amministratore
    22 Merrivale Road
    Pymble
    New South Wales
    2073
    Australia
    Australian62712190001
    PAYNE, Catherine Patricia
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    AustraliaBritish69630880002
    PONNET, Wim Theo Gaby
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceBelgian210379090001
    RICHARDS, Anthony John
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritish138456730002
    SCHWEITZER, Marie Lucile
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceFrench272749510001
    SHIELDS, Paul Bernard
    3 Bramerton Street
    SW3 5JS London
    Amministratore
    3 Bramerton Street
    SW3 5JS London
    United KingdomBritish65682940001
    TOUMAZIS, Thomas Christoforos
    Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    59
    Amministratore
    Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    59
    United KingdomBritish137603910001
    TURNER, Christopher
    The Old House
    Ripley Road, East Clandon
    GU4 7SF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Old House
    Ripley Road, East Clandon
    GU4 7SF Guildford
    Surrey
    British66592560001
    WATTS, Robyn Louise
    93 Surrey Street
    Darlinghurst New South Wales 2010
    FOREIGN Australia
    Amministratore
    93 Surrey Street
    Darlinghurst New South Wales 2010
    FOREIGN Australia
    Australian59078660001
    WILSON, Nigel Peter
    15 Geraldine Road
    SW18 2RD London
    Amministratore
    15 Geraldine Road
    SW18 2RD London
    British96660510001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Endemol Worldwide Distribution Holding Limited
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies Register England And Wales
    Numero di registrazione02461138
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SOUTHERN STAR SALES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 01 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 01 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge incorporating fixed and floating charges between the company, southern star circle PLC oxford scientific films limited and australia and new zealand banking group limited (the "chargee")
    Creato il 23 mar 2001
    Consegnato il 05 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money obligations and liabilities of any kind of each chargor and each security provider to or for the account of the chargee under the terms of the transaction documents (as defined)
    Brevi particolari
    All property assets rights and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2000
    Consegnato il 25 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever provided that there shall be excluded from the foregoing covenant any liability or sum which would but for this proviso cause such covenant or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute unlawful financial assistance prohibited by section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    F/H property located at the west side of lower road long hanborough oxfordshire t/nos ON31609 ON151076 and ON79360 all tangible movable property accounts with the bank intellectual property goodwill by way of floating charge the whole of the companys undertaking and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Westpac Banking Corporation
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 lug 1998
    Consegnato il 12 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the sales and distribution agreements in respect of a television series entitled "bugs-series 4" as bothpresently existing and to be acquired by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 03 lug 1998
    Consegnato il 07 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the sales and distribution agreements in respect of the television series entitled "bugs-series 4" as both presently existing and to be acquired by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 1996
    Consegnato il 13 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 apr 1987
    Consegnato il 13 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an under lease dated 3/4/87
    Brevi particolari
    First floor dumbarton house 68 oxford street, london W1.
    Persone aventi diritto
    • Video Arts Limited
    Transazioni
    • 13 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 set 1980
    Consegnato il 09 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the f/h & l/h properties fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. A charge by way of legal mortgage over l/h property being on the 1ST floor of the building known as 68 oxford street and 1 & 1A perry's place in the parish of st. Marylebone, greater london.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0