HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 01377801
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOUSE OF TRAVEL (WALES) LIMITED19 giu 199219 giu 1992
    C T C TOURS (WALES) LTD31 dic 198131 dic 1981
    COLLEGE TRANSPORT (GWENT) LIMITED10 lug 197810 lug 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b & z convert to rs
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to rs 28/07/2016
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed house of travel (wales) LIMITED\certificate issued on 22/07/16
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 20 giu 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 giu 2016

    • Capitale: GBP 319,564
    3 pagineSH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2015

    Stato del capitale al 02 set 2015

    • Capitale: GBP 319,562
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2014

    Stato del capitale al 02 set 2014

    • Capitale: GBP 319,562
    SH01

    Cessazione della carica di Patrick Moynihan come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew Paul Lang come amministratore in data 30 giu 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 set 2013

    Stato del capitale al 04 set 2013

    • Capitale: GBP 319,562
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Moynihan il 01 set 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Cws (No.1) Limited il 01 set 2013

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Caroline Jane Sellers il 01 set 2013

    2 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Century House Manchester M60 4ES* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    British45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1925625
    130695310001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Segretario
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Segretario
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Segretario
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001
    BELL LANGFORD, David James
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British67740010001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Amministratore
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    COOMBS, Clive
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    British24868440001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritish74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Amministratore
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritish188221460001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritish87719730001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Amministratore
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    SCOTT, Maurice
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    Amministratore
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    EnglandBritish107500770001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Amministratore
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    British87240350002
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001

    HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    197 high street treorchy rhondda cynon taf t/n WA712653.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    53 hannah st,porth,rhondda cynon taf; t/no WA135149.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1998
    Consegnato il 22 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    21 oxford street mountain ash mid glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 13 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    25 beaufort street brynmawr gwent t/no.WA502437.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1996
    Consegnato il 03 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    121A dunraven street tonypandy rhondda cynon taff t/n WA793892.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 ott 1995
    Consegnato il 10 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 29 mar 1994
    Consegnato il 15 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £16,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property at 197 high street treorchy mid glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Alan Roderick Hawkins
    Transazioni
    • 15 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 dic 1988
    Consegnato il 29 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 1985
    Consegnato il 02 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0