STORM OF LEICESTER LTD.

STORM OF LEICESTER LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTORM OF LEICESTER LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01380416
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STORM OF LEICESTER LTD.?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STORM OF LEICESTER LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STORM OF LEICESTER LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VERTIGONE LIMITED25 lug 197825 lug 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di STORM OF LEICESTER LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per STORM OF LEICESTER LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Richard James Maloney come segretario in data 01 gen 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 apr 2016

    Stato del capitale al 12 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2015

    Stato del capitale al 26 mar 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2014

    Stato del capitale al 10 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di STORM OF LEICESTER LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    222329150001
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British75618940001
    BOOTH, Brenda
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    Segretario
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Secretary16249170005
    DALBY, Sonia Christine
    18 Eastfield Road
    LE3 6FE Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    18 Eastfield Road
    LE3 6FE Leicester
    Leicestershire
    British21910150001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    British97753620001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector Secretary21483450001
    PERRY, Brian
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    British10759770001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    ANDREWS, Giles Edward Charles
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    Amministratore
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    BritishDirector37743280001
    BIGGS, Anthony Mark
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector46681000002
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Amministratore
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritishDirector And Accountant29331220001
    BROWN, Angus Lushington Wylie
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector10759780001
    DAVIS, Andrew Michael
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector63557750001
    EGERTON, Peter John
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    Amministratore
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant17294880001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director97753620001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    GIBBON, John Spencer
    82 Coverside Road
    Great Glen
    LE8 9EA Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    82 Coverside Road
    Great Glen
    LE8 9EA Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector21910140001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector Secretary21483450001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    BritishDirector57169010001
    MURRAY, Alec Barclay
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Executive163818290001
    NERDRUM, Arild
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Amministratore
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    NorwegianDirector4137560001
    PATTERSON, Steven Shaw
    126 Knighton Road
    LE2 3TQ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    126 Knighton Road
    LE2 3TQ Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector21910160001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STORM OF LEICESTER LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Godfrey Davis Motor Group
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione860056
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    STORM OF LEICESTER LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 feb 1995
    Consegnato il 17 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings k/a 30 nelson street leicester and all buildings fixtures (other than trade) with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 giu 1993
    Consegnato il 24 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies owing to the company by lotus cars limited in respect of refu nds of monies paid by the company to lotus cars by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 24 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 gen 1992
    Consegnato il 31 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 lug 1989
    Consegnato il 26 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1991Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 23 gen 1992Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 12 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 25 mar 1986
    Consegnato il 07 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares & securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking
    Transazioni
    • 07 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 31 gen 1983
    Consegnato il 07 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge over undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Clore Marris (UK) Limited
    Transazioni
    • 07 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 13 dic 1982
    Consegnato il 23 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed of floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts legal mortgage over:- the garage the nook anstey, charhwood, leicestershire. L/h piece of parcel of land fronting stadon road anstey in the county of leicester and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 dic 1980
    Consegnato il 11 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    15 the nook anstey leicester title no. Lt 105149. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1980
    Consegnato il 05 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land fronting stadon road anstey leicestershire.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1980
    Consegnato il 04 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that leasehold property fronting stadon rd, anstey, leicestershire. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Lambard North Central Limited
    Transazioni
    • 04 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1979
    Consegnato il 03 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    15 the nook, anstey, leices.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1980Registrazione di un'ipoteca

    STORM OF LEICESTER LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 lug 1989Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Dargan
    St Johns House
    East Street
    LE1 6NG Leicester
    Praticante
    St Johns House
    East Street
    LE1 6NG Leicester
    Lindsay Kennedy Denney
    Touche Ross And Co
    St Johns House
    LE1 6NG East Street
    Leicester
    Praticante
    Touche Ross And Co
    St Johns House
    LE1 6NG East Street
    Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0