LG 2009 CO. LIMITED

LG 2009 CO. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLG 2009 CO. LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01381597
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LG 2009 CO. LIMITED?

    • (2852) /

    Dove si trova LG 2009 CO. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gardner Aerospace
    Cotmanhay Road
    DE7 8LL Ilkeston
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LG 2009 CO. LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 200909 mar 200009 mar 2000
    WOLLASTON ENGINEERING LIMITED31 ago 198431 ago 1984
    RETREAT ENGINEERING CO. LIMITED 01 ago 197801 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di LG 2009 CO. LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per LG 2009 CO. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    6 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Cooper come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ago 2008

    6 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ago 2007

    6 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio redatto al 31 ago 2006

    6 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 ago 2005

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ago 2004

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LG 2009 CO. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BHW SOLICITORS
    5 Grove Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SA Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    5 Grove Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SA Leicester
    Leicestershire
    122987010001
    GRADY, Patrick Neill
    The Farmhouse
    Top Yard Farm
    LE16 7JB Great Bowden
    Amministratore
    The Farmhouse
    Top Yard Farm
    LE16 7JB Great Bowden
    EnglandBritishDirector88455710002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant40164810001
    SMITH, Alexander David
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    Segretario
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    British12280540001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Segretario
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    BritishCompany Director90527220001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    Segretario
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    38962110002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    L GARDNER & SONS LIMITED
    Grays Court
    1 Nursery Road Edgbaston
    B15 3JX Birmingham
    Segretario
    Grays Court
    1 Nursery Road Edgbaston
    B15 3JX Birmingham
    68854050002
    APTED, Raymond William
    The Old Granary
    Holt Heath
    WR6 6TA Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Granary
    Holt Heath
    WR6 6TA Worcester
    Worcestershire
    BritishBritishCompany Director61342840002
    BLAIR, David
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director71195900001
    BLAIR, David
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director71195900001
    COOPER, Mark
    4 King Richard Way
    LE65 1LD Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    4 King Richard Way
    LE65 1LD Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector110041350002
    FOX, Andrew Patrick
    4 Silcotes Court
    WF2 0UJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Silcotes Court
    WF2 0UJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector75833000001
    FULLER, Nigel Edward
    NN17 3BA Fineshade
    St. Marys House
    Northamptonshire
    Amministratore
    NN17 3BA Fineshade
    St. Marys House
    Northamptonshire
    BritishDirector138912590001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40164810001
    HOLLIS, Stephen John Bolckow
    14 Ryelands Grove
    BD9 6HJ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Ryelands Grove
    BD9 6HJ Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director78688050001
    MOLLEKIN, Stuart James
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    Amministratore
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    EnglandBritishDirector36939710003
    POWELL, Stephen
    The Coach House
    Thorpe
    DE6 2AW Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    The Coach House
    Thorpe
    DE6 2AW Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director12992520002
    SMITH, Alexander David
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    BritishCompany Director12280540001
    SMITH, Maureen
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    35 Birch Lane
    Stock
    CM4 9NA Ingatestone
    Essex
    BritishCompany Director12280550001
    STANLEY, Nicholas Ronald
    5 Birkdale Drive
    NG17 8PP Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    5 Birkdale Drive
    NG17 8PP Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    BritishDirector71842210001
    WALTON, John
    10 Abbey Fields
    East Hanningfield
    CM3 8XB Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    10 Abbey Fields
    East Hanningfield
    CM3 8XB Chelmsford
    Essex
    BritishEngineer66171820001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Amministratore
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director90527220001
    WHYBROW, Ian Michael
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director43349720001
    WILSON, Kevin
    Poolhead Lane
    Tanworth-In-Arden
    B94 5ED Solihull
    Highland
    West Midlands
    Amministratore
    Poolhead Lane
    Tanworth-In-Arden
    B94 5ED Solihull
    Highland
    West Midlands
    EnglandBritishDirector134562630001

    LG 2009 CO. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and supplemental charge
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 26 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from myradene overseas limited, except any money or liabilities due from myradene overseas limited as guarantor for the company to the chargee including all costs and expenses which the chargee may in the course of its business charge or incur in respect of myradene overseas limited or any of the initial charging companies (as defined) or any of their affairs in accordance with the terms of the facilities agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 nov 1997
    Consegnato il 17 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 19 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other group company (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility letters (as therein defined) and this guarantee and debenture (the "debenture")
    Brevi particolari
    Freehold 79 manton road, corby, northamptonshire, leasehold units 18 and 19 princewood road, earlstree industrial estate, corby, northamptonshire title number NN183245, warehouse premises, south side of whitley way,, airfield industrial estate, ashbourne, derbyshire. See schedule attached to form M395 for full details of the property.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1995
    Consegnato il 30 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 10 dic 1993
    Consegnato il 13 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge over: one amada cnc turner punch press model pega 344 - serial number 3441840. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 18 gen 1985
    Consegnato il 29 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Included trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0