MANOR PROPERTY LIMITED

MANOR PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMANOR PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01382764
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MANOR PROPERTY LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova MANOR PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MANOR PROPERTY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOWERMANOR LIMITED08 ago 197808 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di MANOR PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MANOR PROPERTY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MANOR PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 dic 2014

    22 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 12 dic 2014

    22 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 giu 2014

    19 pagine2.24B

    Cessazione della carica di David Griffiths come amministratore in data 24 giu 2014

    4 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da The Office 41 Woodgates Lane North Ferriby East Yorkshire HU14 3JY in data 05 gen 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    2 pagine2.12B

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    27 dic 2013The form is a duplicate of the TM01 registered on 09/12/2013

    Cessazione della carica di William Henry Addy come amministratore in data 30 nov 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Barnes come amministratore in data 30 set 2013

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr David Griffiths come amministratore in data 01 giu 2013

    3 pagineAP01

    Nomina di Manor Holdings International Ltd come amministratore in data 11 set 2013

    3 pagineAP02

    Bilancio annuale redatto al 26 ago 2013

    19 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 set 2013

    Stato del capitale al 18 set 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2012 al 30 giu 2013

    3 pagineAA01

    Cessazione della carica di Imco Secretary Limited come segretario in data 02 ago 2013

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Riverside East 2 Millsands Sheffield South Yorkshire S3 8DT in data 07 ago 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di Mark Andrew Bailey come amministratore in data 10 ott 2012

    3 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    17 pagineAR01

    Nomina di Mr John Barnes come amministratore in data 08 ago 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di Imco Secretary Limited come segretario in data 16 feb 2012

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da The Office 41 Woodgates Lane North Ferriby North Humberside HU14 3JY United Kingdom in data 23 feb 2012

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di MANOR PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AKRILL, Susan Penny Anne
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandEnglish111841670002
    BAILEY, Mark Andrew
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish147036330001
    LANE, Robert Shales
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish82808830001
    RIX, David Hilaire
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    United KingdomBritish148392520001
    MANOR HOLDINGS INTERNATIONAL LTD
    c/o Hassans
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Gibraltar
    Amministratore
    c/o Hassans
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Gibraltar
    Forma giuridicaLIMITED COMPANY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleGIBRALTAR
    Numero di registrazioneGICO 109451-78
    181701430001
    DENT, Andrew James
    3 Marshall Avenue
    Willerby
    HU10 6LL Hull
    North Humberside
    Segretario
    3 Marshall Avenue
    Willerby
    HU10 6LL Hull
    North Humberside
    British78549900001
    GORDON, Anton Joel
    Main Street
    Shadwell
    LS17 8LA Leeds
    223
    West Yorkshire
    Segretario
    Main Street
    Shadwell
    LS17 8LA Leeds
    223
    West Yorkshire
    British34929600002
    JOHNSON, Andrew Kevin
    Holderness House
    Market Place
    HU15 2AT South Cave
    North Humberside
    Segretario
    Holderness House
    Market Place
    HU15 2AT South Cave
    North Humberside
    British37704690002
    IMCO SECRETARY LIMITED
    c/o Irwin Mitchell Llp
    Wellington Place
    LS1 4BZ Leeds
    2
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o Irwin Mitchell Llp
    Wellington Place
    LS1 4BZ Leeds
    2
    West Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione44449984
    167272620001
    LUPFAW SECRETARIAL LIMITED
    Yorkshire House
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Lupton Fawcett,
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Yorkshire House
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Lupton Fawcett,
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04077390
    150192860001
    MANOR ADMINISTRATION LIMITED
    The Office
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    North Humberside
    Segretario
    The Office
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    North Humberside
    119092430001
    SWANLAND HALL SECRETARIES LTD
    Providence House Navigation Road
    Burslem
    ST6 3BQ Stoke On Trent
    Segretario
    Providence House Navigation Road
    Burslem
    ST6 3BQ Stoke On Trent
    42321320001
    ADDY, William Henry
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    Amministratore
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    United KingdomBritish75193160003
    AKRILL, Amanda Jane
    8 Castle Hill
    LN1 3AA Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    8 Castle Hill
    LN1 3AA Lincoln
    Lincolnshire
    British40608240002
    AKRILL, Philip Robert
    41 Woodgates Lane
    North Ferriby
    HU14 3JY Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    41 Woodgates Lane
    North Ferriby
    HU14 3JY Hull
    East Yorkshire
    EnglandBritish41447310002
    BARNES, John
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    Amministratore
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    United KingdomBritish31573990001
    CARO, Michael Jon
    96 Station Road
    Waddington
    LN5 9QS Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    96 Station Road
    Waddington
    LN5 9QS Lincoln
    Lincolnshire
    British45536180003
    FIELDSEND, Richard Michael
    South Lawn House
    Aisthorpe
    LN1 2SG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    South Lawn House
    Aisthorpe
    LN1 2SG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish16358690004
    GALBRAITH, David Benjamin
    63 Wolfreton Garth
    Kirk Ella
    HU10 7AB Hull
    North Humberside
    Amministratore
    63 Wolfreton Garth
    Kirk Ella
    HU10 7AB Hull
    North Humberside
    British46704630002
    GALBRAITH, David Benjamin
    69 Oaklands Drive
    Willerby
    HU10 6BJ Hull
    North Humberside
    Amministratore
    69 Oaklands Drive
    Willerby
    HU10 6BJ Hull
    North Humberside
    British46704630001
    GRIFFITHS, David
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish63817680001
    MARTIN, Robert William
    c/o Lupton Fawcett
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Yorkshire House
    West Yorkshire
    Amministratore
    c/o Lupton Fawcett
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Yorkshire House
    West Yorkshire
    UkBritish148392350001
    TURNER, David Kevin
    Brook House
    Longwater Lane
    RG11 4NT Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Brook House
    Longwater Lane
    RG11 4NT Finchampstead
    Berkshire
    British35307490002

    MANOR PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 26 mag 2005
    Consegnato il 04 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land on the west side of ladysmith road grimsby.
    Persone aventi diritto
    • Philip Robert Akrill and Amanda Jane Akrill
    Transazioni
    • 04 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 2003
    Consegnato il 07 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at melton/welton east yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 2002
    Consegnato il 03 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land on the west side of ladysmith road grimsby north east lincolnshire t/n HS293841. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage land on the west side of ladysmith road grimsby t/n HS293841. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 11 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 20 apr 1995
    Consegnato il 26 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole that area or pice of land in the city od edingburgh and the county of midlothian forming part of the subjects formerly k/a craigmillar creamery and lying on the south side of the road leading from edinburgh to musselburgh called niddrie mains road. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 feb 1995
    Consegnato il 02 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transazioni
    • 02 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 20 lug 1993
    Consegnato il 10 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date
    Brevi particolari
    The property as detailed on the reverse of the form M395 ref M887C & continuation sheets.
    Persone aventi diritto
    • Rdm Factors Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 19 lug 1993
    Consegnato il 29 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground extending to two thousand seven hundred and sixty five square feet or thereby being the plot or area of ground described on a plan.together with the fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 07 gen 1993
    Consegnato il 14 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cold store at 98 niddrie mains road, craigmillar, edinburgh forming part of the subjects commonly k/a craigmillar creamery and lying on the south side of the road leading from edinburgh to mussleburgh (for full details see form 395 tc ref: M40C).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 21 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at borrowash road derby t/n dy 121725.
    Persone aventi diritto
    • Darwin Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 21 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at derby road derby t/n dy 54902.
    Persone aventi diritto
    • Darwin Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 1991
    Consegnato il 10 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at borrowash road spondon t/no: dy 121725.
    Persone aventi diritto
    • Darwin Limited
    Transazioni
    • 10 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 feb 1988
    Consegnato il 29 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, l/h property k/as 164 derby road borrowash, derby title no. Dy 54902 together with all buildings & fixtures thereon. The goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 10 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £140,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a principal charge.
    Brevi particolari
    F/H property k/a spondon leisure centre, derby road, spondon, derbyshire title no. Dy 121726.
    Persone aventi diritto
    • Manns Northampton Brewery Company Limited.
    Transazioni
    • 10 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 set 1986
    Consegnato il 15 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the east side of borrowash rd, spondon.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 set 1986
    Consegnato il 08 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a spondon leisure centre borrowash road, spondon derby.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1985
    Consegnato il 08 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H spondon leisure centre derby road spondon derbyshire T.N. dy 121726.
    Persone aventi diritto
    • Manns Northampton Brewery Company Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 03 dic 1984
    Consegnato il 07 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £37,519 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of derby road spondon k/a spondon leisure centre t/n:- dy 121726.
    Persone aventi diritto
    • Manns Northampton Brewery Company Limited.
    Transazioni
    • 07 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1984
    Consegnato il 26 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the east side of borrowash road spondon derby, derbyshire t/n:- dy 121725.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 05 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the maltings, anglesey road, burton on trent, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 feb 1983
    Consegnato il 09 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All those pieces of land together with the buildings situate in borrowash road, spondon, derbyshire. (Freehold).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1982
    Consegnato il 14 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises situate at clarke street, derby T. no. Dy 25255.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1982Registrazione di un'ipoteca

    MANOR PROPERTY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 dic 2013Inizio dell'amministrazione
    12 dic 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0