VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED

VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01382864
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VILLAGE SQUASH LIMITED08 ago 197808 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 20

    5 pagineMR05

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR

    2 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Sunita Kaushal come segretario in data 29 lug 2014

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * 33 Cavendish Square London London W1G 0PW England* in data 29 mag 2014

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mag 2014

    Stato del capitale al 29 mag 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* in data 28 ago 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di David Caldecott come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 01 lug 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Colin Elliot come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 nov 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 05 set 2012

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 25 mag 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Maxwell Coppel il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Segretario
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    British15541980001
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Segretario
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158962570001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    Segretario
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    TURNOCK, Stephen Barry
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Segretario
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    British107764580001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BIRD, Paul Francis
    Foxhills 4 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Foxhills 4 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    British89181330001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    EnglandBritish73603940004
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    DERMODY, Paul Bernard
    6 Roe Green
    Worsley
    M28 2RF Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    6 Roe Green
    Worsley
    M28 2RF Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2207400002
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish109155280002
    HARRISON, Jonathan Charles
    Brambletye
    New Mill Road
    RG40 4QT Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Brambletye
    New Mill Road
    RG40 4QT Finchampstead
    Berkshire
    British51526360001
    LAKE, Trevor Rex
    Glen Royd
    15 Saint Albans Road
    HX3 0ND Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Glen Royd
    15 Saint Albans Road
    HX3 0ND Halifax
    West Yorkshire
    British38334390003
    MCNALLY, Anthony Francis
    7 Bell Meadow Court
    CW6 0DT Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    7 Bell Meadow Court
    CW6 0DT Tarporley
    Cheshire
    British63045710001
    REED, Stuart James
    9 Elm Rise
    Prestbury
    SK10 4US Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    9 Elm Rise
    Prestbury
    SK10 4US Macclesfield
    Cheshire
    British2250490001
    REID, Hubert Valentine
    The Old Rectory
    Cocksmoss Lane Marton
    SK11 9HX Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Cocksmoss Lane Marton
    SK11 9HX Macclesfield
    Cheshire
    British34122950001
    SINGH, Jagtar
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish121710890001
    SINGLETON, Paul James
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    British79357110001
    STOREY, Martin John
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    Amministratore
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    British35968160001
    STUBBS, Roger Gordon
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish4795660002
    TURNOCK, Stephen Barry
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish107764580001
    ZANRE, Renaldo
    Lyndale Beechcroft
    BR7 5DB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Lyndale Beechcroft
    BR7 5DB Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish11893590001

    VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 mar 2010
    Consegnato il 17 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 17 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 set 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1987
    Consegnato il 07 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 and any other monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brevi particolari
    Fixed charge over:- premises at george st. Prestwich manchester and premises in dukinfield rd, hyde, cheshire. Fixed & moveable plant equipment, furniture, fixtures, fittings. Goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons' Breweries Limited.
    Transazioni
    • 07 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 lug 1986
    Consegnato il 18 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Brevi particolari
    1) fixed charge over premises in dukinfield road, hyde, cheshire 2) fixed & moveable plant equipment furniture, fixtures, fittings. 3) goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons' Breweries Public Limited Company
    Transazioni
    • 18 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1986
    Consegnato il 16 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and any other moneys that may become owing by the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Brevi particolari
    Village squash club hyde cheshire tog with the goodwill of the business and the book & other debts please see doc M29.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Webster and Wilsons Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 feb 1986
    Consegnato il 25 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £125,000 and any other moneys that may become owing by the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brevi particolari
    Fixed charge over (a) f/h premises at george st prestwich manchester (b) premises at dukinfield rd hyde cheshire all the fixed moveable plant equipment furniture fixtures & fittings affixed or situate about the properties, the goodwill of the business carried on at or from the properties.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons' Breweries Public Limited Company.
    Transazioni
    • 25 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 set 1985
    Consegnato il 12 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £200,000 and any monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brevi particolari
    Village squash club george street, prestwich and village squash club dukinfield road, hyde. Title no gm 356483 gm 193646 and gm 232244 together with the goodwill of the business and book debts.
    Persone aventi diritto
    • Wilsons Brewery Limited
    Transazioni
    • 12 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mar 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 apr 1985
    Consegnato il 12 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £330,546
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south west side of george street prestwich bury greater manchester land lying to the west of dukinfield road hyde and land k/a newton wood house dukinfield rd hyde tameside greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Thornham Construction Company LTD
    Transazioni
    • 12 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 apr 1985
    Consegnato il 09 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M24. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Credit Services Limited
    Transazioni
    • 09 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1984
    Consegnato il 04 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H newton wood house dukinfield road hythe greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 31 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £94666.72 and any other moneys that may become owing by the company tothe chargee on account current of stated for goods supplied or otherwise.
    Brevi particolari
    F/H land & premises situate in george street, prestwich bury, greater manchester title no:- gm 232244 all fixed and moveable plant equipment fixtures and fittings goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons' Brewers Public Limited Company
    Transazioni
    • 31 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1982
    Consegnato il 08 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the village, george stret off bury new road sedgley park prestwich manchester greater manchester title no gm 232244.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1982
    Consegnato il 08 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the west of dukinfield road now a squash complex captain clark road off dukinfield road hyde greater manchester title no gm 193646.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 09 set 1982
    Consegnato il 16 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. And all fixtures plant and machinery (please see doc M16).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1982
    Consegnato il 07 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land on the west side of george street prestwich bury. Title no gm 232244.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons Breweries Public Limited Company
    Transazioni
    • 07 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 gen 1982
    Consegnato il 15 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & bldgs. Registered under title no:- gm 232244 tog. With the goodwill of the business carried on thereat.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Credit Services Limited
    Transazioni
    • 15 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    Irrevocable authority
    Creato il 05 feb 1981
    Consegnato il 17 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Squash complex captain clarke road off dukinfield road hyde, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    Irrevocable authority
    Creato il 05 feb 1981
    Consegnato il 10 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1.75 acres of land on the south side of george street, prestwich greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 09 dic 1980
    Consegnato il 12 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises being 1.75 acres situate on the south side of george street prestwich, bury greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 24 ott 1980
    Consegnato il 30 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises known as squash complex, captain clarke road, off dukinfield road, hyde cheshire. Title no:- gm 193646. tog. With all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 28 mag 1980
    Consegnato il 11 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over (see doc M9). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0