MSQ HOLDINGS LIMITED

MSQ HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMSQ HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01382912
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MSQ HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUTTS HOLDINGS LIMITED14 dic 200414 dic 2004
    COUTTS HOLDINGS PLC.04 mag 200404 mag 2004
    C.A. COUTTS HOLDINGS PLC11 apr 199611 apr 1996
    ESSEX HOLDINGS LIMITED09 ago 197809 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 28 feb 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10 Rathbone Place London W1T 1HP England a C/O Browne Jacobson Llp 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ

    1 pagineAD04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 pagineAD03

    Bilancio redatto al 29 feb 2016

    21 pagineAA

    Stato del capitale al 22 set 2016

    • Capitale: GBP 0.20
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 21/09/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2016

    Stato del capitale al 24 mar 2016

    • Capitale: GBP 4,043,722.2
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2015

    Stato del capitale al 06 feb 2015

    • Capitale: GBP 4,043,722.2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    AD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    AD02

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 28 feb 2014

    15 pagineAA

    legacy

    29 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776860001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Executive147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Segretario
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    British7666350001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343420001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Amministratore
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishChartered Accountant7666350001
    BECKETT, John Douglas Hamilton
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    Amministratore
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    BritishSemi-Retired Consultantant7666360001
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector71758630001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CAHN, Christopher Charles
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    Amministratore
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishDirector85328320001
    CUBBON, James Henry
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector47485650002
    ESSEX, Charles Edward Oliver
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishSales Representative7666370001
    ESSEX, Norman Arthur
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director7666380001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    Amministratore
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishCompany Director7666390002
    ESSEX, William Alexander Wells
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    BritishMagazine Editor7666400001
    FOWLER, Robert Edward
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    Amministratore
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector26408910001
    HARRIS, Graeme Richard
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    Amministratore
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    EnglandBritishDirector56342040002
    HIGSON, Alexander
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    Amministratore
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    BritishExecutive Recruitment7666410001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Amministratore
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Amministratore
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritishExec Chairman41614380002
    PENN, John Robert
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    Amministratore
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomEnglishNone7147450002
    SAYSELL, Richard Geoffrey
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    Amministratore
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    BritishDirector50920320002
    SMITH, Anthony Michael
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector26408890003
    STERN, Nigel Duncan
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    Amministratore
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    BritishDirector58083200002
    WHITEHORN, William Elliott
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    Amministratore
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    United KingdomBritishDirector46878420002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MSQ HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    06 apr 2016
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione07745643
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MSQ HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 21 lug 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 18 lug 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 04 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Hong kong law share charge
    Creato il 07 set 2012
    Consegnato il 19 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged assets meaning the shares and derivative assets and includes all rights benefits and sums now or in the future accruing as a result of or in connection with any of the shares or the derivative assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 19 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 23 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    New york law stock pledge agreement
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 17 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the other obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in the pledged shares and additional collateral and any certificates and instruments see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 14 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest in the existing shares, any additional shares, any derived assets and any dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 14 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 20 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share mortgage
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the securities being the original securities and additional securities including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share charge
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's interest in the shares being 100 ordinary shares of £1.00 each in the company and related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Cession and pledge in security
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares and ceded rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Acting as Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate group holdings gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing share in the aggregate nominal amount of 20,000 euro in the pledged company being hoffmann schalt werbeagentur gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right, title and interest in and to its pledged stock and a senior, first priority lien in all of the pledgor's right, title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing shares and related rights and any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 ott 2004
    Consegnato il 22 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 feb 1984
    Consegnato il 07 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as bakery premises forming part of the borough of chelmsford's widford industrial estate at robyohns road chelmsford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0