G.W. CHEMICALS LIMITED

G.W. CHEMICALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG.W. CHEMICALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01384952
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G.W. CHEMICALS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova G.W. CHEMICALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Zenith Hygiene Group
    A1 (M) Business Centre
    AL9 7JE Dixons Hill Road Welham Green
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di G.W. CHEMICALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per G.W. CHEMICALS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per G.W. CHEMICALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium reserve reduced 24/02/2015
    RES13

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2014

    Stato del capitale al 26 feb 2014

    • Capitale: GBP 19,304
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Clock House 140 London Road Guildford Surrey GU1 1UW

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Arvinder Walia come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Arvinder Walia come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Arvinder Singh Walia il 18 ago 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ringo Daisley Francis il 18 ago 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Arvinder Singh Walia il 18 ago 2010

    3 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    9 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    Chi sono gli amministratori di G.W. CHEMICALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRANCIS, Ringo Daisley, Mr.
    A1 (M) Business Centre
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House
    Hertfordshire
    Amministratore
    A1 (M) Business Centre
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector109799320001
    GEE, Geoffrey Alan
    Ingledene 21 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    Segretario
    Ingledene 21 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    British10039850001
    HESELTINE, Stephen
    Ouston House
    Ouston Lane
    LS24 8DP Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    Ouston House
    Ouston Lane
    LS24 8DP Tadcaster
    North Yorkshire
    British26904810005
    SELBY, Ian Robert
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    Segretario
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    BritishAccountant102101830001
    WALIA, Arvinder Singh
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    Segretario
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    British57238690003
    COLWELL, Richard Anthony
    47 Mardley Hill
    Oaklands
    AL6 0TT Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    47 Mardley Hill
    Oaklands
    AL6 0TT Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director97480080001
    COSGROVE, Alan
    12 Whitebeam Close
    WA15 7YS Timperley
    Cheshire
    Amministratore
    12 Whitebeam Close
    WA15 7YS Timperley
    Cheshire
    BritishIntegration Manager109799580001
    FRANCIS, Ringo Daisley, Mr.
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    Amministratore
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director109799320001
    GEE, Geoffrey Alan
    Ingledene 21 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ingledene 21 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    BritishIndustrial Chemist10039850001
    GRACIE, Gavin Hugh
    57 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    57 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    UkZimbabweanDirector70976100003
    HESELTINE, Stephen
    Ouston House
    Ouston Lane
    LS24 8DP Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ouston House
    Ouston Lane
    LS24 8DP Tadcaster
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Director26904810005
    HESELTINE, Stephen
    18 Oulton Drive
    Oulton Park
    L26 Leeds
    Amministratore
    18 Oulton Drive
    Oulton Park
    L26 Leeds
    BritishFinancial Director26904810001
    LITTLE, Patrick William
    315a Huntington Road
    YO3 9PX York
    North Yorkshire
    Amministratore
    315a Huntington Road
    YO3 9PX York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director193215380001
    SELBY, Ian Robert
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant102101830001
    WALIA, Arvinder Singh
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    Amministratore
    Dixons Hill Road
    AL9 7JE Welham Green
    Zenith House A1 (M) Business Centre
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector57238690003
    WILLIAMS, Andrew James
    The Old Rectory
    YO61 4RJ Brandsby
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    YO61 4RJ Brandsby
    North Yorkshire
    United KingdomBritishSales Representative23304650001

    G.W. CHEMICALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 09 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 2000
    Consegnato il 12 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property being land on north side of the old rectory,town st,breandsby,north yorkshire; nyk 195060.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 12 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and C.M.R. chemical services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 18 mag 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £23660.40
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 26 mag 1992
    Consegnato il 11 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17975-30 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances. (See 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 11 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 04 lug 1991
    Consegnato il 13 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,911-70
    Brevi particolari
    All its right, title and interest of the company. (Please see doc 395 tc ref M138C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 1989
    Consegnato il 13 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of hopwood works, littlebank street, oldham, greater manchester, title no la 33706.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 1986
    Consegnato il 01 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37.5 acres of land adjoining the old rectory, brandsby N. yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1985
    Consegnato il 19 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 2, ainleys industrial estate, ainley bottom elland west yorkshire, title no wyk 334906.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 1982
    Consegnato il 20 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the south west of huddersfield road elland west yorkshire title no wyk 213407.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 giu 1982
    Consegnato il 09 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. (See doc M20).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 set 1980
    Consegnato il 08 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H plot of land known as plot 1 on the councils ainleys industrial estate near huddersfeld road, elland, in the county of west yorkshire with factory buildings erectred thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Borough Council of Calderdale
    Transazioni
    • 08 ott 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0