MILTON MARKETING LIMITED

MILTON MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILTON MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01385429
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILTON MARKETING LIMITED?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MILTON MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sea Containers House
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILTON MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILTON MARKETING (ADVERTISING AND DESIGN) LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    IDPOINT LIMITED24 ago 197824 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILTON MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MILTON MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicholas Paul Douglas come amministratore in data 23 giu 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Robertson Payne come amministratore in data 23 giu 2023

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 16 mag 2023

    • Capitale: GBP 10,001
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Nicholas Paul Douglas come amministratore in data 30 set 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charles Ward Van Der Welle come amministratore in data 30 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 08 lug 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Richard James Payne come amministratore in data 01 lug 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Milton Marketing Group Limited come persona con controllo significativo il 05 dic 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 27 Farm Street London W1J 5RJ a Sea Containers House 18 Upper Ground London SE1 9GL in data 13 apr 2022

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    10 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Wpp Group (Nominees) Limited il 26 nov 2018

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Steve Richard Winters come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MILTON MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Segretario
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    PAYNE, Richard James
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    EnglandBritish298052910001
    CALOW, David Ferguson
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Segretario
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    British91285750001
    MILTON, William Leslie
    Lads Love Dean Lane
    Cookham
    SL6 9BG Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Lads Love Dean Lane
    Cookham
    SL6 9BG Maidenhead
    Berkshire
    British9448490001
    TURNBULL, Andrew John
    Holcombe House
    Shurlock Row
    RG10 0PR Twyford
    Berkshire
    Segretario
    Holcombe House
    Shurlock Row
    RG10 0PR Twyford
    Berkshire
    British25303300001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Segretario
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    BOLAND, Andrew Kenneth
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British71264540005
    BOURNE, Michael John
    15 Eton Square
    SL4 6BG Eton
    Berkshire
    Amministratore
    15 Eton Square
    SL4 6BG Eton
    Berkshire
    British83012670001
    BUSS, Jeremy David
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    United Kingdom British 26720550002
    CARTER, Wendy Margaret
    15 Eton Square
    Eton
    SL4 6BG Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    15 Eton Square
    Eton
    SL4 6BG Windsor
    Berkshire
    British3871990001
    CONAGHAN, Daniel Patrick
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    EnglandBritish260161530001
    DELANEY, Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish69254240002
    DIAMOND, Stuart
    22 Woodland Place Great Neck
    New York 11021
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    22 Woodland Place Great Neck
    New York 11021
    FOREIGN Usa
    American59579970001
    DOUGLAS, Nicholas Paul
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    EnglandBritish301114610001
    HAM, David Fenton
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish103819950001
    MILTON, William Leslie
    The Tithe Barn Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Tithe Barn Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HG Reading
    Berkshire
    British9448490002
    PAYNE, Andrew Robertson
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    EnglandBritish202208380001
    RICHARDSON, Paul Winston George
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    Amministratore
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    British45700660003
    SCOTT, Andrew Grant Balfour
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish67078370001
    SWEETLAND, Christopher Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    EnglandBritish56529540005
    TURNBULL, Andrew John
    Holcombe House
    Shurlock Row
    RG10 0PR Twyford
    Berkshire
    Amministratore
    Holcombe House
    Shurlock Row
    RG10 0PR Twyford
    Berkshire
    British25303300001
    WELLE, Charles Ward Van Der
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    United KingdomBritish181492230001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Amministratore
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    WILSON, Stephen Michael
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    Amministratore
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    British81144620001
    WINTERS, Steve Richard
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    Amministratore
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    EnglandBritish210160610001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILTON MARKETING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    06 apr 2016
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3113109
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MILTON MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 26 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (And Its Successors in Title) for and on Behalf of Itself Thenoteholders and the Banks and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Finance Documents
    Transazioni
    • 26 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC for and on Behalf of Itself and the Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Bridge Facility Agreement
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 nov 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ago 1986
    Consegnato il 21 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property comprising part of basement, ground floor and first, second and third floors of 1 thames street windsor in berkshire t/n bk 172741 and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 giu 1983
    Consegnato il 24 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof: fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. Legal mortgage over first floor offices (area d) hempstead house, basingstoke hampshire and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0