EUROTRAIL UK LIMITED

EUROTRAIL UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROTRAIL UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01385650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROTRAIL UK LIMITED?

    • Noleggio e leasing di camion e altri veicoli pesanti (77120) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova EUROTRAIL UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EUROTRAIL UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROTRAIL DISTRIBUTION CONTRACTS LIMITED11 apr 199511 apr 1995
    INTERTRAIL LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    TREC TRAILER SERVICES LIMITED25 ago 197825 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROTRAIL UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROTRAIL UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Andrew Crossland il 05 dic 2023

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 10 nov 2023

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    24 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Andrew Crossland il 26 giu 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Robert Furnival il 26 giu 2023

    2 pagineCH01

    Notifica di Tip Trailer Services Uk Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione di Grayrentals Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Grayrentals Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione di Steers Group Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2022

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 013856500035, creata il 08 dic 2022

    54 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 013856500034, creata il 23 ago 2022

    52 pagineMR01

    Nomina di Oakwood Corporate Secretary Limited come segretario in data 04 feb 2022

    2 pagineAP04

    Nomina di Mark Andrew Crossland come amministratore in data 14 gen 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Alain Fast come amministratore in data 14 gen 2022

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2022 al 31 dic 2022

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2021

    20 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Steers Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di EUROTRAIL UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    CROSSLAND, Mark Andrew
    Pontefract Road
    WF11 8SP Knottingley
    Hill Top
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Road
    WF11 8SP Knottingley
    Hill Top
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director212229670002
    FURNIVAL, Michael Robert
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    England
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director199461480001
    BOOTH, Alan
    54 Chesterfield Road
    Tibshelf
    DE55 5NL Alfreton
    Derbyshire
    Segretario
    54 Chesterfield Road
    Tibshelf
    DE55 5NL Alfreton
    Derbyshire
    BritishDirector74128370001
    CALLEAR, David James
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    British41483090001
    COLLINS, John Wilfred James
    The Barn
    Chithurst Lane Trotton
    GU31 5ET Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    The Barn
    Chithurst Lane Trotton
    GU31 5ET Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Secretary2074480001
    JOB, Michael Nicholas
    North View House
    Main Street,
    HG4 3RY Kirkby Malzeard
    North Yorkshire
    Segretario
    North View House
    Main Street,
    HG4 3RY Kirkby Malzeard
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant81696930001
    MARSDEN, Sarah
    15 Aspen Close
    Gomersal
    BD19 4NY Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    15 Aspen Close
    Gomersal
    BD19 4NY Cleckheaton
    West Yorkshire
    BritishFinance Manager123943660003
    STEERS, Alan
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    Segretario
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    BritishDirector77625030001
    STEERS, Alan
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    Segretario
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    BritishDirector77625030001
    WRIGHT, Paul Reginald
    Snowberry Mill Lane
    YO2 1TZ Acaster Malbis
    North Yorkshire
    Segretario
    Snowberry Mill Lane
    YO2 1TZ Acaster Malbis
    North Yorkshire
    British40283470001
    ANDERSON, Alexander Campbell
    Kaitness Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HE Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Kaitness Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HE Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director43710680001
    AVEYARD, Peter
    15 Gladstone Terrace
    Morley
    LS27 9LE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Gladstone Terrace
    Morley
    LS27 9LE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector39033720001
    BOOTH, Alan
    54 Chesterfield Road
    Tibshelf
    DE55 5NL Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    54 Chesterfield Road
    Tibshelf
    DE55 5NL Alfreton
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector74128370001
    CALLEAR, David James
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishAccountant41483090001
    CALLEAR, David James
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishAccountant41483090001
    CAYGILL, Adrian
    23 Grouse Moor Lane
    Queensbury
    BD13 1NS Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Grouse Moor Lane
    Queensbury
    BD13 1NS Bradford
    West Yorkshire
    BritishOperations Director57366650002
    COWPER, Alanajohn
    37 Arrendene Road
    CB9 9JQ Haverhill
    Suffolk
    Amministratore
    37 Arrendene Road
    CB9 9JQ Haverhill
    Suffolk
    BritishDirector74128390001
    EVANS, Marshall Owen
    Warwick House
    47 Stewkley Road Wing
    LU7 0NJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    Warwick House
    47 Stewkley Road Wing
    LU7 0NJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    United KingdomBritishOperations Director42930970001
    EVELEIGH, Brendan
    Koningin Emmalaan 13
    1405 Cj Bussum
    FOREIGN The Netherlands
    Amministratore
    Koningin Emmalaan 13
    1405 Cj Bussum
    FOREIGN The Netherlands
    BritishFinance Director35859570001
    FAST, Robert Alain
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    England
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    England
    NetherlandsAmericanCeo89843360002
    JOB, Michael Nicholas
    North View House
    Main Street,
    HG4 3RY Kirkby Malzeard
    North Yorkshire
    Amministratore
    North View House
    Main Street,
    HG4 3RY Kirkby Malzeard
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant81696930001
    STEERS, Adam John
    27 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8PX Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    27 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8PX Huddersfield
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector74128380002
    STEERS, Alan
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    Amministratore
    Lea Swallows Farm
    Pond Lane Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    United KingdomBritishDirector77625030001
    STEERS, Jane Carolyn
    Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    Lea Swallow Barn
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Little Lepton
    HD8 0LW Huddersfield
    Lea Swallow Barn
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director87226030001
    STEERS, Mathew Alan
    Copley Drive
    HX3 0US Halifax
    31
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Copley Drive
    HX3 0US Halifax
    31
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector288939500003
    STRATTON, Philip Jack
    12 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishDirector60688160001
    VAN HULTEN, Jacoba Christina Maria
    Bladstraat 37
    Utrecht 3572 Hv
    FOREIGN Netherlands
    Amministratore
    Bladstraat 37
    Utrecht 3572 Hv
    FOREIGN Netherlands
    DutchLawyer54852860001
    VAN NIEUWKERK, Jan Robert
    Prins Bernhardlaan 2
    Amstelveen
    1183 Be
    Netherlands
    Amministratore
    Prins Bernhardlaan 2
    Amstelveen
    1183 Be
    Netherlands
    DutchFinance Director38219260001
    WRIGHT, Paul Reginald
    Snowberry Mill Lane
    YO2 1TZ Acaster Malbis
    North Yorkshire
    Amministratore
    Snowberry Mill Lane
    YO2 1TZ Acaster Malbis
    North Yorkshire
    BritishChartered Secretary40283470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EUROTRAIL UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    07 nov 2022
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2620554
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    07 nov 2022
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione8570225
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Steers Group Limited
    West End Approach
    Morley
    LS27 0NB Leeds
    C/O Eurotrail Uk Limited
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    West End Approach
    Morley
    LS27 0NB Leeds
    C/O Eurotrail Uk Limited
    West Yorkshire
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione02891333
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EUROTRAIL UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 dic 2022
    Consegnato il 13 dic 2022
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Coöperatieve Rabobank U.A.
    Transazioni
    • 13 dic 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 ago 2022
    Consegnato il 30 ago 2022
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Coöperatieve Rabobank U.A.
    Transazioni
    • 30 ago 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 feb 2021
    Consegnato il 05 mar 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • De Lage Landen Leasing Limited
    Transazioni
    • 05 mar 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 feb 2021
    Consegnato il 10 feb 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 gen 2017
    Consegnato il 03 feb 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Leasing LTD
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2014
    Consegnato il 15 nov 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 mar 2014
    Consegnato il 26 mar 2014
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C. T/a Allied Irish Bank (GB)
    Transazioni
    • 26 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2013
    Consegnato il 17 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monies due to the company under rental agreements relating to vehciles which are to become subject of hire purchase leasing rental or contract hire agreement with the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Paccar Financial PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge over sub-hire agreements
    Creato il 15 set 2010
    Consegnato il 20 set 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the secured property being all the right title interest and benefit in and to the sub-hire agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 20 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 nov 2008
    Consegnato il 03 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Vehicles being mercedes benz actros 2544 high roof cab 6X2 new serial no YC58HBY 01/12/2008,mercedes benz actros 2544 high roof club 6X2 new YC58HBX 01/12/2008,mercedes benz actros 2544 high roof cab 6X2 new YC58HBZ 01/12/2008 (for further deatils of vehicles charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 25 nov 2008
    Consegnato il 03 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Volvo FM9 300 4X2 drawbar new YJ08AEO 10/05/2008,FM9 300 4XR drawbar new YJ08AEZ 17/05/2008,volvo FM9 300 4X2 drawbar new YJ08AEW 10/05/2008 for further details of vehicles charged please refer to form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 20 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subcontracts entered into at any time by the company with customer(s) relating to the vehicles or other goods owned by the chargee and comprised in the principal contracts, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Man Financial Services PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Long term licence to sub-let (with security)
    Creato il 15 apr 2008
    Consegnato il 01 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assets funded from time to time with ing lease (UK) LTD.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 01 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment and charge
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 18 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £379,250.55 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Ref EUR0213 - 2 x daf ftg CF85.430 6 x 2 space cab tractor units reg no YK06AFO chassis no E724433 and reg no YK06AFU chassis no E724440, ref EUR0214 - 2 x sdc tri-deck trailers with palfinger PKK8500 rolloader km 332 grab kennis base chassis no 66524 crane ser no 100041367 kennis base s/no 82007 and chassis no 66525 crane ser no 100041368 kennis base s/no 82008 and ref EUR0216 - 1 x daf ftg CF85.430 6 x 2 space cab tractor unit reg no YK06AFV chassis no E724438 for details of fjuther equipment charged please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment and charge
    Creato il 26 giu 2006
    Consegnato il 01 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £379,250.55 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    3 x sdc tri-deck trailers with palfinger PKK8500 rol loader, KM332 grab, kennis base s/nos. 100040875, 100040876 and 100040960 and 3 x daf ftg CF85.430 Space cab tractor units reg nos. YJO6AFF, YKO6AFJ and YKO6AFN. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment and charge
    Creato il 22 giu 2006
    Consegnato il 01 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £252,833.70 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    2 x sdc tri-deck trailers with palfinger PKK8500 rol loader, KM332 grab, kennis base s/nos. 100040877 and 100041446 and 2 x daf ftg CF85.430 Space cab tractor units reg nos. YKO6AFA and YKO6AFE. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 22 mag 2006
    Consegnato il 23 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sub-hiring agreements all moneys payable under the sub-hiring agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 23 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A sub hire agreement
    Creato il 28 apr 2006
    Consegnato il 09 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sub hire or sub lease agreements of goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Handelsbanken Finans Ab (Publ)
    Transazioni
    • 09 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Creato il 30 set 2005
    Consegnato il 05 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's rights, title and interest in the sub leases in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements together with the benefit of all collateral agreements guarantees, insuranace policies,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplementary schedule
    Creato il 11 lug 2005
    Consegnato il 13 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's rights, title and interest in the sub-hire agreements as defined in the asset sub-hire agreement and includes any hire purchase contract or contract for sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 13 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture (charge on hire contracts)
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 04 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monies due under hire agreements.
    Persone aventi diritto
    • Paccar Financial Limited
    Transazioni
    • 04 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplementary schedule
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment and charge
    Creato il 05 mar 2004
    Consegnato il 16 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £106,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros drawbar 2544 trailer crane, registration number MX53 hhn, vin number WDB9302042K873024.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment and charge
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £949,896.79 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of the equipment as shown in more detail in schedule 1 of page 14 of the security assignment and charge.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First fixed charge
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 20 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By first fixed charge all sub-lease agreements entered into at any time by the company with customers of the company relating to the goods now or hereafter owned by the company but let by dcs to the company under hire purchase agreements or lease agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daimlerchrysler Services UK Limited
    Transazioni
    • 20 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0