CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED

CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01388817
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 5 Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHEMICAL REACTOR SERVICES (BOLTON) LIMITED14 set 197814 set 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2015

    Stato del capitale al 08 ott 2015

    • Capitale: GBP 2,110
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ United Kingdom a Unit 5 Lyon Road Industrial Estate Kearsley Bolton BL4 8TG in data 12 gen 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Alastair James Fleming come amministratore in data 30 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alison May Sloan come segretario in data 30 dic 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 dic 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Goldsmith come amministratore in data 30 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Andrew Crawford Wills come amministratore in data 30 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Kathryn Patricia Mccann come segretario in data 30 dic 2014

    2 pagineAP03

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Martin Street Audenshaw Manchester Lancashire M34 5JA a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ in data 30 ott 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2014

    Stato del capitale al 01 ott 2014

    • Capitale: GBP 2,110
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alastair James Fleming il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2013

    Stato del capitale al 30 set 2013

    • Capitale: GBP 2,110
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2013

    4 pagineAA

    Nomina di Alastair James Fleming come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Valentine come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCANN, Kathryn Patricia
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    Segretario
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    194021920001
    GOLDSMITH, Mark
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    Amministratore
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    ScotlandBritishManager116117890001
    WILLS, Andrew Crawford
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    Amministratore
    Lyon Road Industrial Estate
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Unit 5
    United Kingdom
    GermanyBritishEngineer194018860001
    BARBOUR, George Thomson
    25 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    Segretario
    25 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    British27824610002
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    177048350001
    OTTIWELL, Ian Frank
    The Stables
    Leslie Mains
    KY6 3EP Glenrothes
    Fife
    Segretario
    The Stables
    Leslie Mains
    KY6 3EP Glenrothes
    Fife
    BritishFinancial Controller85306120002
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    BARBOUR, George Thomson
    25 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    Amministratore
    25 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    BritishCompany Director27824610002
    CAMPBELL, Robert Stewart
    648 Mendon Road
    FOREIGN Pittsford
    New York 14534
    Usa
    Amministratore
    648 Mendon Road
    FOREIGN Pittsford
    New York 14534
    Usa
    AmericanBusiness Executive30787230001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Amministratore
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritishUk Country Controller180854890001
    GORDON, Ronald Ross
    14 The Roundel
    Lundin Links
    KY8 6HN Leven
    Fife
    Amministratore
    14 The Roundel
    Lundin Links
    KY8 6HN Leven
    Fife
    BritishGeneral Manager27824600002
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishVp Finance Europe162062160001
    OTTIWELL, Ian Frank
    The Stables
    Leslie Mains
    KY6 3EP Glenrothes
    Fife
    Amministratore
    The Stables
    Leslie Mains
    KY6 3EP Glenrothes
    Fife
    United KingdomBritishFinancial Controller85306120002
    RIGOT, Joseph
    2000 Courthouse Plaza Ne
    45402 Dayton
    Ohio
    Usa
    Amministratore
    2000 Courthouse Plaza Ne
    45402 Dayton
    Ohio
    Usa
    AmericanAttorney40040120001
    VALENTINE, Steven Grenville
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector92773870002
    WILLS, Andrew Crawford
    Lyon Road
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Lyon Road
    Kearsley
    BL4 8TG Bolton
    Lancashire
    GermanyBritishGeneral Manager49757700008
    WRIGHTON, Anthony Herbert
    5 The Glebe
    Albrighton
    WV7 3EF Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    5 The Glebe
    Albrighton
    WV7 3EF Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector42609640001

    CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a 228 somerton road and garage breightmet, bolton, greater manchester title no. GM173544 and a fixed charge over plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land being the sites of 11 to 17 (odd nos.) nicholas street, bolton, greater manchester title no. GM26532 and f/h land being land and buildings on the north east side of windley street, bolton, greater manchester title no. GM360775 and a fixed charge over plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land being land and buildings lying to the south of springfield road, kearsley, lancashire title no. LA333174 and a fixed charge over all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ott 1988
    Consegnato il 24 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the south of springfield road kearsley (now k/as unit 5 lyon industrial estate) lancashire title no. La 333174 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 1984
    Consegnato il 11 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land in nicholas street balton greater manchester tn gm 26532 f/h roberts buildings windley street balton greater manchester and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0