CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01388817 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit 5 Lyon Road Industrial Estate Kearsley BL4 8TG Bolton |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHEMICAL REACTOR SERVICES (BOLTON) LIMITED | 14 set 1978 | 14 set 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ United Kingdom a Unit 5 Lyon Road Industrial Estate Kearsley Bolton BL4 8TG in data 12 gen 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair James Fleming come amministratore in data 30 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alison May Sloan come segretario in data 30 dic 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Goldsmith come amministratore in data 30 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Andrew Crawford Wills come amministratore in data 30 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Kathryn Patricia Mccann come segretario in data 30 dic 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Martin Street Audenshaw Manchester Lancashire M34 5JA a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ in data 30 ott 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 07 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alastair James Fleming il 07 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Alastair James Fleming come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Valentine come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCANN, Kathryn Patricia | Segretario | Lyon Road Industrial Estate Kearsley BL4 8TG Bolton Unit 5 United Kingdom | 194021920001 | |||||||
GOLDSMITH, Mark | Amministratore | Lyon Road Industrial Estate Kearsley BL4 8TG Bolton Unit 5 United Kingdom | Scotland | British | Manager | 116117890001 | ||||
WILLS, Andrew Crawford | Amministratore | Lyon Road Industrial Estate Kearsley BL4 8TG Bolton Unit 5 United Kingdom | Germany | British | Engineer | 194018860001 | ||||
BARBOUR, George Thomson | Segretario | 25 Lundin View KY8 5TL Leven Fife | British | 27824610002 | ||||||
FLEMING, Alastair James | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 177048350001 | |||||||
OTTIWELL, Ian Frank | Segretario | The Stables Leslie Mains KY6 3EP Glenrothes Fife | British | Financial Controller | 85306120002 | |||||
SLOAN, Alison May | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
BARBOUR, George Thomson | Amministratore | 25 Lundin View KY8 5TL Leven Fife | British | Company Director | 27824610002 | |||||
CAMPBELL, Robert Stewart | Amministratore | 648 Mendon Road FOREIGN Pittsford New York 14534 Usa | American | Business Executive | 30787230001 | |||||
FLEMING, Alastair James | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | Uk Country Controller | 180854890001 | ||||
GORDON, Ronald Ross | Amministratore | 14 The Roundel Lundin Links KY8 6HN Leven Fife | British | General Manager | 27824600002 | |||||
O'NEIL, Christopher Paul | Amministratore | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | Vp Finance Europe | 162062160001 | ||||
OTTIWELL, Ian Frank | Amministratore | The Stables Leslie Mains KY6 3EP Glenrothes Fife | United Kingdom | British | Financial Controller | 85306120002 | ||||
RIGOT, Joseph | Amministratore | 2000 Courthouse Plaza Ne 45402 Dayton Ohio Usa | American | Attorney | 40040120001 | |||||
VALENTINE, Steven Grenville | Amministratore | Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe 4 United Kingdom | England | British | Director | 92773870002 | ||||
WILLS, Andrew Crawford | Amministratore | Lyon Road Kearsley BL4 8TG Bolton Lancashire | Germany | British | General Manager | 49757700008 | ||||
WRIGHTON, Anthony Herbert | Amministratore | 5 The Glebe Albrighton WV7 3EF Wolverhampton West Midlands | British | Director | 42609640001 |
CHEMICAL REACTOR SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 04 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land k/a 228 somerton road and garage breightmet, bolton, greater manchester title no. GM173544 and a fixed charge over plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land being the sites of 11 to 17 (odd nos.) nicholas street, bolton, greater manchester title no. GM26532 and f/h land being land and buildings on the north east side of windley street, bolton, greater manchester title no. GM360775 and a fixed charge over plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land being land and buildings lying to the south of springfield road, kearsley, lancashire title no. LA333174 and a fixed charge over all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 14 ott 1988 Consegnato il 24 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings lying to the south of springfield road kearsley (now k/as unit 5 lyon industrial estate) lancashire title no. La 333174 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 27 set 1984 Consegnato il 11 ott 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land in nicholas street balton greater manchester tn gm 26532 f/h roberts buildings windley street balton greater manchester and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0