MILLETS SHOPS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MILLETS SHOPS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01389207 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MILLETS SHOPS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MILLETS SHOPS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 440-450 Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MILLETS SHOPS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MILLETTS SHOPS (MSS) LIMITED | 05 giu 1995 | 05 giu 1995 |
OLYMPUS SPORTSWORLD LIMITED | 30 giu 1993 | 30 giu 1993 |
MILLETTS SHOPS SCOTLAND LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
GARRYGLASS LIMITED | 15 set 1978 | 15 set 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MILLETS SHOPS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 26 feb 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per MILLETS SHOPS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Derrick Beacham come segretario in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Julia Reynolds come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Derrick Beacham come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Marcello Lombardo come amministratore in data 16 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 21 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Ms Julia Reynolds come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 39 pagine | MA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Hitt come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark Derrick Beacham come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Consolidamento delle azioni al 05 nov 2010 | 9 pagine | SH02 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 40 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 feb 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard John Hitt il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MILLETS SHOPS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACHAM, Mark Derrick | Segretario | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||
FOOT, Peter John Lewis | Segretario | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | 51176110002 | ||||||
HALL, Vikki | Segretario | 28 Burman Drive Coleshill B46 3NB Birmingham | British | 82602670001 | ||||||
O'KEEFFE, Mark John | Segretario | 5 Fowey Close NN8 5WW Wellingborough Northamptonshire | British | 57880430001 | ||||||
PILLAY, Paul Vijayasingam | Segretario | 69 Lilleshall Avenue Monkston MK10 9HU Milton Keynes | Other | Head Of Finance & Company Secr | 79416150001 | |||||
QUINLAN, Diane | Segretario | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 38760910001 | ||||||
SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC | Segretario | Sunningdale Road LE3 1TP Leicester | 16600870001 | |||||||
ASTLEY, Brian Martin | Amministratore | 25 Marjorie Grove SW11 5SH London | British | Director | 75795040001 | |||||
BEACHAM, Mark Derrick | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 160095260001 | ||||
CHAMBERLAIN, Adrian | Amministratore | Butlers Hall Wareside SG12 7QL Ware Hertfordshire | British | Director | 117106730001 | |||||
CROSLAND, Roy Nicholson | Amministratore | 35 Addison Avenue W11 4QS London | British | Director | 30882970002 | |||||
DRUM, John David Francis | Amministratore | 1 Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | Company Secretary | 13103440003 | |||||
FALLON, John Edward | Amministratore | Gardeners Cottage Old Hall Drive Widmerpool Keyworth NG12 5PZ Nottingham | British | Director | 52124910001 | |||||
FLEMING, Keith | Amministratore | Brookmead House The Warren, East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | England | British | Director | 112723440002 | ||||
FOOT, Peter John Lewis | Amministratore | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 51176110002 | |||||
HARDY, Russell Stephen Mons | Amministratore | The Reddings Langley Road, Claverdon CV35 8P Warwick Warwickshire | England | British | Chief Executive | 45844210003 | ||||
HARTLEY, Peter Christopher | Amministratore | 17 Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull | United Kingdom | British | Finance Director | 96458190001 | ||||
HITT, Richard John | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Business Analysis & Insight | 127468180001 | ||||
JONES, Anthony David | Amministratore | 32 Cross Lane Mountsorrel LE12 7BY Loughborough Leicestershire | British | Director | 41640680001 | |||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 137285750001 | ||||
LIS, Andrew Richard | Amministratore | 139 Clapham Road SW99 0HR London | British | Group Tax Manager | 62660110001 | |||||
LOASBY, Andrew | Amministratore | 3 The Banks NN9 5YX Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 48081840002 | |||||
LOMBARDO, Marcello | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | England | British | Finance Director | 135699240001 | ||||
MALONE, Desmond Philip | Amministratore | 1 Morpeth B77 1JF Tamworth Staffordshire | England | British | Director | 87170450001 | ||||
MAYWOOD, Terry Osborn | Amministratore | Longston House School Lane Islip NN14 3LQ Kettering Northamptonshire | British | Retail Director | 39631730004 | |||||
MEEHAN, Andrew David | Amministratore | Southview Church Lane Lighthorne CV35 0AT Warwick | England | British | Director | 62737150001 | ||||
REYNOLDS, Julia | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 United Kingdom | England | British | Chief Executive | 127468460001 | ||||
SHEATH, Christopher Gordon | Amministratore | Avonlea Hop Gardens, Whiteparish SP5 2SS Salisbury Wiltshire | British | Finance Director | 69543550002 | |||||
STAINES, Michael John | Amministratore | 4 Fleetwind Drive NN4 0ST Northampton Northamptonshire | British | Director | 16626330001 | |||||
VICKERS, Alan Christopher | Amministratore | The Ashes 8 Cross Hedge Rothley LE7 7RR Leicester Leicestershire | British | Director | 1971520001 |
MILLETS SHOPS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creato il 04 mar 1996 Consegnato il 13 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charges | Creato il 13 set 1985 Consegnato il 16 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixied & floating charges over goodwill & book debt & other debts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0